Michael Sheldon SILVERSTONE
  • Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Michael Sheldon SILVERSTONE - Seite 11

    Natürliche Person

    Titel
    VornameMichael
    Zweites VornamenSheldon
    NachnameSILVERSTONE
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv0
    Inaktiv0
    Zurückgetreten441
    Gesamt441

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    TAXVAT LIMITED17. Okt. 199418. Okt. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    HOLBORN TAX CONSULTANCY LTD17. Okt. 199418. Okt. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    ZABOU CLOTHING COMPANY LTD17. Okt. 199418. Okt. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    JANES MEADOW (12 FLATS) MANAGEMENT COMPANY LIMITED13. Okt. 199414. Okt. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    7 STRATFORD STREET (NO. 2) LIMITED06. Okt. 199407. Okt. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    DRINKS MARKETING CONSORTIUM LIMITED30. Sept. 199403. Okt. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    SMART COATINGS LIMITED28. Sept. 199429. Sept. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    RFC (UK) LIMITED23. Sept. 199426. Sept. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    INTERNATIONAL TOOL COMPANY LIMITED23. Sept. 199426. Sept. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    CHESHIRE PRINT & DESIGN LTD22. Juli 199422. Sept. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    ASSOCIATED SUPPLIES LIMITED30. Aug. 199416. Sept. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    CRUCIBLE TECHNOLOGIES LTD06. Sept. 199408. Sept. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    LINCOLN WELDING SUPPLIES LTD05. Sept. 199408. Sept. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    GOLD STAR CONSTRUCTION CO. LTD30. Aug. 199405. Sept. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    RIDGE (GATLEY) LIMITED31. Aug. 199401. Sept. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    R.J. MILES LTD22. Aug. 199423. Aug. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    ENERGYLINC LIMITED16. Aug. 199416. Aug. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    WPI CIVIL ENGINEERING LIMITED11. Aug. 199412. Aug. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    TAMESIDE TAXIS LTD10. Aug. 199412. Aug. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    3DD ENTERTAINMENT LTD10. Aug. 199411. Aug. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    COLOSSUS TECHNOLOGY LTD20. Juni 199402. Aug. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    BASEMENT JO LIMITED29. Juli 199401. Aug. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    SWIRLING DERVISH LIMITED22. Juli 199426. Juli 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    WORKROOM PRODUCTIONS LTD22. Juli 199420. Juli 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    MAPLE LEAF SERVICES LTD19. Juli 199420. Juli 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    BORDITT AND LEGITT LTD06. Juli 199407. Juli 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    CORNUCOPIA DESIGNS LTD01. Juli 199404. Juli 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    LITIGRAPHICS LTD.28. Juni 199429. Juni 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    INFINITY HERITAGE LTD28. Juni 199429. Juni 1994Freiwillige VereinbarungBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    ETC U.K. LTD16. Juni 199417. Juni 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    HOUSE OF HAMPTON LTD10. Juni 199413. Juni 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    THE S AND D EXTRACTION COMPANY LTD01. Juni 199402. Juni 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    BRITISH AMERICAN PRODUCTIONS LTD19. Mai 199419. Mai 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    LIGNACITE (BRANDON) LIMITED13. Mai 199418. Mai 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    D.S.P. LIMITED13. Mai 199418. Mai 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0