Michael Sheldon SILVERSTONE - Seite 2
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Michael |
Zweites Vornamen | Sheldon |
Nachname | SILVERSTONE |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 441 |
Gesamt | 441 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE CUTTING COMPANY (HAMPSHIRE) LTD | 08. Juli 1998 | 08. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
WASTE LOGISTICS LTD | 03. Juli 1998 | 03. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
THE LEGENDARY JOE BLOGGS INCORPORATED COMPANY LIMITED | 03. Juli 1998 | 03. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
MECHANDLING LIMITED | 02. Juli 1998 | 02. Juli 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
R.G. DEVELOPMENTS (SCOTLAND) LTD. | 02. Juli 1998 | 02. Juli 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
HLA UNIVERSAL LIMITED | 02. Juli 1998 | 02. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
TAILOR-MADE ACCOUNTANCY SERVICES LIMITED | 02. Juli 1998 | 02. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
ENIGMA QPM LIMITED | 29. Juni 1998 | 29. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
BLACKHEATH PHOTOSET LTD | 26. Juni 1998 | 26. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
AVONICS LTD | 22. Juni 1998 | 22. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
BOND RECRUITMENT LIMITED | 19. Juni 1998 | 19. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
JESMOND RESIDENTIAL LTD | 10. Juni 1998 | 10. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
PREMIER PAINTING CONTRACTORS LTD | 10. Juni 1998 | 10. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
MANCHESTER ROOFING COMPANY LTD | 05. Juni 1998 | 09. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
NISUMI LTD | 05. Juni 1998 | 09. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
LARNIER LTD | 05. Juni 1998 | 09. Juni 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
CARE TODAY (CHILDRENS SERVICES) LTD | 05. Juni 1998 | 08. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
FIFTY SEVEN MANAGEMENT LIMITED | 05. Juni 1998 | 08. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
COMPACTCADDY LTD | 05. Juni 1998 | 08. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
LEXINGTON FREIGHT FORWARDING LTD | 05. Juni 1998 | 08. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
ASHLEY LAWRENCE LTD | 05. Juni 1998 | 05. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
FUND ACCOUNTING SERVICES LIMITED | 07. Mai 1998 | 03. Juni 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
72 MUSWELL HILL ROAD LTD | 26. Mai 1998 | 26. Mai 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
CAMBERTON LTD | 18. Mai 1998 | 26. Mai 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
BRACKTON LTD | 08. Mai 1998 | 22. Mai 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
LODGE PROPERTY INVESTMENTS LTD | 18. Mai 1998 | 18. Mai 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
SUPCO LTD | 18. Mai 1998 | 18. Mai 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
SHAHBAAZ INDIAN CUISINE LTD | 15. Mai 1998 | 18. Mai 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
PHILLIPS FIRE PROTECTION LIMITED | 15. Mai 1998 | 18. Mai 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
DED ASSOCIATES LTD | 11. Mai 1998 | 11. Mai 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
K A H CONSULTANCY LTD | 08. Mai 1998 | 11. Mai 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
WHELEC LIMITED | 07. Mai 1998 | 08. Mai 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
GSC (UK) LTD | 01. Mai 1998 | 05. Mai 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
THE LONDON LUNCH BOX COMPANY LTD | 01. Mai 1998 | 05. Mai 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
ORPHEUS INVESTMENTS LTD | 30. Apr. 1998 | 01. Mai 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0