Michael Sheldon SILVERSTONE - Seite 8
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Michael |
Zweites Vornamen | Sheldon |
Nachname | SILVERSTONE |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 441 |
Gesamt | 441 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCARTHUR DEAN TRAINING LIMITED | 06. Dez. 1995 | 08. Dez. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
WELLINGTON PUB MANAGEMENT LIMITED | 05. Dez. 1995 | 06. Dez. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
QUIZWORLD LTD | 01. Dez. 1995 | 05. Dez. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
CONTRACT GENERAL SERVICES SUPPORT LTD | 01. Dez. 1995 | 05. Dez. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
ROLLING EDGE (DESIGN) LIMITED | 01. Dez. 1995 | 05. Dez. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
R. THOMSON (ELECTRICAL CONTRACTORS) LIMITED | 29. Nov. 1995 | 30. Nov. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
CORPORATE INTERIOR DESIGN (UK) LTD | 27. Nov. 1995 | 29. Nov. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
CUMMINS, MELLOR SEARCH LTD | 14. Nov. 1995 | 15. Nov. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
FOUR. B. H. LTD | 03. Nov. 1995 | 06. Nov. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
TOPS CLOTHING & WORKWEAR COMPANY LIMITED | 03. Nov. 1995 | 06. Nov. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
CARNVALE LTD | 30. Okt. 1995 | 06. Nov. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
A K GOYMER & CO LTD | 27. Okt. 1995 | 30. Okt. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
43 CROUCH HALL ROAD MANAGEMENT LTD | 27. Okt. 1995 | 30. Okt. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
STRATHMERE LTD | 28. Sept. 1995 | 23. Okt. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
P.J. INTERCONNECT LTD | 13. Okt. 1995 | 18. Okt. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
J R GOFF AND W F TILE LTD | 19. Sept. 1994 | 12. Okt. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
SANDILANDS LTD | 06. Okt. 1995 | 11. Okt. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
DIRECT BUSINESS SOLUTIONS LIMITED | 22. Sept. 1995 | 27. Sept. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
RIVERVIEW LTD | 15. Sept. 1995 | 21. Sept. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
MARCHFIELD LTD | 13. Sept. 1995 | 20. Sept. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
EXPRESS TAX LIMITED | 13. Sept. 1995 | 14. Sept. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
MICROPLAN INTERNATIONAL LIMITED | 07. Sept. 1995 | 11. Sept. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
TAYLOR ELECTRICAL DISTRIBUTORS (STOCKPORT) LTD | 07. Sept. 1995 | 08. Sept. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
CROMFORD LTD | 10. Aug. 1995 | 07. Sept. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
QUAY (N.E.) LEISURE LIMITED | 25. Aug. 1995 | 29. Aug. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
N.G. ELECTRONICS LIMITED | 25. Aug. 1995 | 29. Aug. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
FISHWICK SERVICES LTD. | 28. Juli 1995 | 17. Aug. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
BRENTFIELD ENTERPRISES LTD | 14. Juni 1995 | 14. Aug. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
SHIPPING & TRADING COMPANY (MANCHESTER) LIMITED | 07. Aug. 1995 | 10. Aug. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
K3 LIMITED | 03. Aug. 1995 | 04. Aug. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
KEY LETS LTD | 25. Juli 1995 | 26. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
ANNIVERSARY SOFTWARE SERVICES LIMITED | 14. Juli 1995 | 17. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
PEP COMPUTER SERVICES LTD | 11. Juli 1995 | 12. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
HURFORD SALVI CARR LIMITED | 11. Juli 1995 | 12. Juli 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
SENECA COMPUTER SERVICES LTD | 11. Juli 1995 | 12. Juli 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0