Michael Sheldon SILVERSTONE
  • Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Michael Sheldon SILVERSTONE - Seite 12

    Natürliche Person

    Titel
    VornameMichael
    Zweites VornamenSheldon
    NachnameSILVERSTONE
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv0
    Inaktiv0
    Zurückgetreten441
    Gesamt441

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    HARRIER COMMUNICATIONS LTD06. Mai 199409. Mai 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    GEMS (CHELTENHAM) LIMITED03. Mai 199405. Mai 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    CURVACEOUS LIMITED03. Mai 199404. Mai 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    CURVACEOUS SOFTWARE LIMITED03. Mai 199404. Mai 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    WESTACOMBE BARNS DRAINAGE MANAGEMENT LIMITED22. Apr. 199425. Apr. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    C.N. CLADDING LTD15. Apr. 199418. Apr. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    M E BRYAN LTD08. Apr. 199411. Apr. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    SES AUTOPARTS LIMITED25. März 199429. März 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    AMPLESPACE LTD25. März 199429. März 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    WELLOW CONSULTING LIMITED25. März 199429. März 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    WHITELEAF CONTRACT FURNITURE LIMITED08. März 199414. März 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    CAPITAZ LTD09. März 199411. März 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    SQUIRRELS BUSINESS SERVICES LTD07. März 199408. März 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    RAINSEAL TRADE WINDOWS LTD.07. März 199407. März 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    E.O.M.(ELECTRICAL CONTRACTORS)LTD17. Feb. 199421. Feb. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    MEADOWROSE SCIENTIFIC LIMITED13. Jan. 199418. Feb. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    CLANDON COURT RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED15. Feb. 199416. Feb. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    BALLRACING DEVELOPMENTS LTD09. Feb. 199410. Feb. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    H. S. (ENVIRONMENTAL) LTD08. Feb. 199409. Feb. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    LODGE CARE SERVICES LTD02. Feb. 199403. Feb. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    NURSING ASSESSMENT AND DISABILITY ADVISORY SERVICE LTD28. Jan. 199431. Jan. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    C K (CORNWALL) LTD.25. Jan. 199426. Jan. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    SECURITYCENTRE LIMITED25. Jan. 199426. Jan. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    LOGIC INTERNATIONAL LTD21. Jan. 199424. Jan. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    FALCON SECURITIES (UK) LTD21. Jan. 199424. Jan. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    HORSLEY BROTHERS LIMITED16. Dez. 199319. Jan. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    PRECISION CUTTING LTD.12. Jan. 199413. Jan. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    CENTURY PARK TRADING INTERNATIONAL LIMITED22. Dez. 199304. Jan. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    MURRAY RIX (NORTHERN) LTD.07. Dez. 199304. Jan. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    OLIKA LTD23. Dez. 199329. Dez. 1993AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    Y BWTHYN CYF22. Dez. 199329. Dez. 1993AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    SILKWORM LTD.14. Dez. 199316. Dez. 1993AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    TRULY SCRUMPTIOUS (UK) LIMITED09. Dez. 199313. Dez. 1993AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    EAGLE HOUSE FINANCIAL SERVICES LTD08. Dez. 199311. Dez. 1993AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    PCF GROUP PLC18. Okt. 199307. Dez. 1993LiquidationBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0