Howard THOMAS - Page 157
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Howard |
Nom de famille | THOMAS |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 7 |
Démissionné | 7852 |
Total | 7859 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREFLARE LIMITED | 16 sept. 1998 | 16 sept. 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
TIMEWORKS LIMITED | 14 sept. 1998 | 14 sept. 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
GEO TECHNOLOGIES LIMITED | 09 sept. 1998 | 09 sept. 1998 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
IRONWOOD PICTURES LIMITED | 08 sept. 1998 | 08 sept. 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
WHITEHOUSE LEISURE INTERNATIONAL LIMITED | 08 sept. 1998 | 08 sept. 1998 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
CLAYHALL CONSULTANTS LIMITED | 08 sept. 1998 | 08 sept. 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
REVEL-CHION, BOREHAM AND COMPANY LIMITED | 07 sept. 1998 | 07 sept. 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
3 JERNINGHAM ROAD MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 04 sept. 1998 | 04 sept. 1998 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
G D HUGHES MANAGEMENT PROJECTS LIMITED | 03 sept. 1998 | 03 sept. 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
P.L. MATTHEWS PLUMBING & HEATING LIMITED | 03 sept. 1998 | 03 sept. 1998 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
LUMASENSE TECHNOLOGIES LIMITED | 01 sept. 1998 | 01 sept. 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
CURVE INTERIORS LIMITED | 01 sept. 1998 | 01 sept. 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BEECHES RESIDENTS ASSOCIATION (WARMINSTER) LIMITED | 01 sept. 1998 | 01 sept. 1998 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
MCGRATH BROS ENGINEERING GROUP LIMITED | 27 août 1998 | 16 sept. 1998 | Liquidation | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
WILMSLOW PLUMBING AND HEATING LIMITED | 27 août 1998 | 27 août 1998 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
ADVENT MAINTENANCE SERVICES LIMITED | 26 août 1998 | 26 août 1998 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
WELWYN GARDEN CITY VISIONPLUS LIMITED | 26 août 1998 | 26 août 1998 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
WINDYRIDGE PROPERTY SERVICES LIMITED | 25 août 1998 | 25 août 1998 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
STAGGERING WINES LIMITED | 24 août 1998 | 24 août 1998 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
CAMERON SCOTT LIMITED | 24 août 1998 | 28 août 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
LOUISE SALKOW LIMITED | 24 août 1998 | 24 août 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
TAKIS PROPERTIES LIMITED | 24 août 1998 | 15 sept. 1998 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
CARE IN THE SHIRES LIMITED | 24 août 1998 | 24 août 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
29 AGAR GROVE MANAGEMENT LIMITED | 21 août 1998 | 21 août 1998 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
LAND SHARK LIMITED | 19 août 1998 | 19 août 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
AIRTEK SAFETY LIMITED | 18 août 1998 | 18 août 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
DANIEL CHANDLER LOAN CENTRE LIMITED | 18 août 1998 | 18 août 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
RND SYSTEMS INTEGRATION LIMITED | 18 août 1998 | 18 août 1998 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
REDCAR VISIONPLUS LIMITED | 17 août 1998 | 17 août 1998 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
REDCAR SPECSAVERS LIMITED | 17 août 1998 | 17 août 1998 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SPRINKLER ENGINEERING LIMITED | 17 août 1998 | 17 août 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SYNXSPEED POST PRODUCTION GROUP LIMITED | 12 août 1998 | 27 août 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
RITEHOLD LIMITED | 12 août 1998 | 06 sept. 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
MEADOW FARM SHERIFFHALES LIMITED | 12 août 1998 | 12 août 1998 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BACTON AGENCY SERVICES LIMITED | 12 août 1998 | 11 sept. 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0