• Données
  • Grande-Bretagne
  • Entreprises
  • Rechercher des entreprises
  • Sanctions
  • Rechercher des sanctions
  • Howard THOMAS - Page 162

    Personne physique

    Titre
    PrénomHoward
    Nom de familleTHOMAS
    Est un dirigeant de sociétéNon
    Nominations
    Actif0
    Inactif7
    Démissionné7852
    Total7859

    Nominations

    Dirigeants nommés
    Nommé(e) àDate de nominationDate de démissionStatut de la sociétéProfessionRôleAdressePays de résidenceNationalité
    AGS ENTERPRISES LIMITED23 avr. 199823 avr. 1998DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CARSPECT (UK) LIMITED22 avr. 199822 avr. 1998DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    20 BURNBURY ROAD LIMITED21 avr. 199821 avr. 1998ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    FORDBRIDGE ENGINEERING LIMITED21 avr. 199821 avr. 1998DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DARK LIGHT DEVELOPMENTS LIMITED21 avr. 199821 avr. 1998ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BROWN RUDNICK LIMITED21 avr. 199821 avr. 1998ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    2 GUILFORD STREET LIMITED15 avr. 199831 mars 1999ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    RAYNERS BAKERY LIMITED15 avr. 199815 avr. 1998DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    260 FERME PARK ROAD (RESIDENTS ASSOCIATION) LIMITED14 avr. 199814 avr. 1998ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    AIMTOAID LIMITED14 avr. 199801 mai 1998ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DIRECT DISCOUNT STORES LIMITED14 avr. 199814 avr. 1998ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WELLINGBOROUGH VISIONPLUS LIMITED14 avr. 199807 mai 1998ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    VERMIN X ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED08 avr. 199808 avr. 1998ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    METAMORPHOSIS MANAGEMENT LIMITED07 avr. 199807 avr. 1998ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SA RETURNS LIMITED07 avr. 199809 avr. 1998ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PORTSMOUTH VISIONPLUS LIMITED07 avr. 199807 mai 1998ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    METAMORPHOSIS PRODUCTIONS LIMITED07 avr. 199813 mai 1998LiquidationSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    FLASHGUARD LIMITED07 avr. 199830 avr. 1998ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SPIRIT DESIGN CONSULTANTS LIMITED07 avr. 199807 avr. 1998DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    TELLING POINT LIMITED06 avr. 199806 avr. 1998DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WOODSIDE CARS LIMITED03 avr. 199803 avr. 1998DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ST. JOHN DEVELOPMENTS LIMITED02 avr. 199802 avr. 1998ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    FLYING BRANDS LIMITED01 avr. 199801 avr. 1998DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PRINTPLAY LIMITED31 mars 199802 avr. 1998DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    G.T. WINDOWS LIMITED30 mars 199830 mars 1998LiquidationSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    AAI/ACL TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED30 mars 199830 mars 1998DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MERALI'S (IOM) LIMITED25 mars 199825 mars 1998ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MERALI'S LIMITED25 mars 199825 mars 1998ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MEDGAL CARE LIMITED25 mars 199825 mars 1998DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LOVEITTS FINANCIAL PLANNING LIMITED24 mars 199824 mars 1998DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CENTRAL PROPERTY ESTATES LIMITED23 mars 199823 mars 1998DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LA MANCHA LIMITED20 mars 199820 mars 1998ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PLANTCARE FOLIAGE DISPLAY SPECIALISTS LIMITED20 mars 199820 mars 1998ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MOBILECALL LIMITED20 mars 199820 avr. 1998DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BAROTE (LONDON) LIMITED20 mars 199820 mars 1998ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0