• Données
  • Grande-Bretagne
  • Entreprises
  • Rechercher des entreprises
  • Sanctions
  • Rechercher des sanctions
  • Howard THOMAS - Page 196

    Personne physique

    Titre
    PrénomHoward
    Nom de familleTHOMAS
    Est un dirigeant de sociétéNon
    Nominations
    Actif0
    Inactif7
    Démissionné7852
    Total7859

    Nominations

    Dirigeants nommés
    Nommé(e) àDate de nominationDate de démissionStatut de la sociétéProfessionRôleAdressePays de résidenceNationalité
    WOODROUGH RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED22 déc. 199422 déc. 1994ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MISCELLANEA HOTELS AND LEISURE LIMITED22 déc. 199422 déc. 1994ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SEAQUIST CLOSURES LIMITED21 déc. 199421 déc. 1994DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BOWES HOTELS LIMITED20 déc. 199420 déc. 1994DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PAT LEWIS & SON LIMITED20 déc. 199420 déc. 1994DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DELPHI ASSETS LIMITED20 déc. 199420 déc. 1994ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ITEM WALES LTD.20 déc. 199420 déc. 1994DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SAPORI D' ITALIA UK LIMITED20 déc. 199420 déc. 1994LiquidationSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    XWV LIMITED19 déc. 199419 déc. 1994DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    GAS CENTRE LIMITED19 déc. 199419 déc. 1994ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    HELMAC PRODUCTS LIMITED19 déc. 199430 janv. 1995DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    GRANDOMAN LIMITED19 déc. 199422 déc. 1994ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MINEHOME LIMITED19 déc. 199419 déc. 1994ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    EPS SOFTWARE LIMITED16 déc. 199416 déc. 1994DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    EDINBURGH VISIONPLUS LIMITED09 déc. 199401 janv. 1995ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SECURITY DOG UNITS UK LIMITED09 déc. 199409 déc. 1994DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    METAL REDUCTION PROCESSING LIMITED08 déc. 199408 déc. 1994DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    EURO REP LIMITED05 déc. 199405 déc. 1994DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    EVOLUTION CLOTHING CO LIMITED01 déc. 199401 déc. 1994DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    THE FRIARY HOTEL LIMITED01 déc. 199401 déc. 1994DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    G.K. BEN & ASSOCIATES LIMITED29 nov. 199429 nov. 1994DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    YOUNG TECHNICAL SERVICES LIMITED29 nov. 199429 nov. 1994ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WOLVERSTON ESTATES LIMITED28 nov. 199428 nov. 1994DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CARBROSAH LTD28 nov. 199428 nov. 1994ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    R & S PLANT HIRE LIMITED25 nov. 199425 nov. 1994DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    P R ENGINEERING LIMITED25 nov. 199425 nov. 1994ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CIFE LIMITED22 nov. 199422 nov. 1994DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PRESTON VISIONPLUS LIMITED22 nov. 199422 nov. 1994ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PENTOAK LIMITED16 nov. 199416 nov. 1994DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    FRIENDS OF EXMOOR PONIES LIMITED16 nov. 199419 déc. 1994ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    TUNBRIDGE WELLS VISIONPLUS LIMITED09 nov. 199409 nov. 1994ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DMX SERVICES LIMITED09 nov. 199409 nov. 1994DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    TUNBRIDGE WELLS SPECSAVERS LIMITED09 nov. 199409 nov. 1994ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ROUNDWAY COURT MANAGEMENT COMPANY LIMITED07 nov. 199407 nov. 1994ActiveSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    COVENT GARDEN HOTEL LIMITED07 nov. 199409 déc. 1994DissouteSecrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0