Howard THOMAS - Page 72
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Howard |
Nom de famille | THOMAS |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 7 |
Démissionné | 7852 |
Total | 7859 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCRI (UK) LIMITED | 08 août 2003 | 08 août 2003 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
PORTUS CONSULTING (LEAMINGTON) LIMITED | 08 août 2003 | 08 août 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
51 SANDMERE ROAD LIMITED | 07 août 2003 | 07 août 2003 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BUY IT LOVE IT.COM LIMITED | 07 août 2003 | 07 août 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
WELLWENT (EIRE) LIMITED | 07 août 2003 | 07 août 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SUPASOUND LIMITED | 07 août 2003 | 07 août 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
ELITE GRINDING SERVICES LIMITED | 07 août 2003 | 07 août 2003 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
TWIST'S HAIR LIMITED | 06 août 2003 | 06 août 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
TONY CRANK LIMITED | 06 août 2003 | 06 août 2003 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
HERITAGE DEVELOPMENTS LIMITED | 06 août 2003 | 06 août 2003 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
ONLINE SOLUTIONS UK LIMITED | 04 août 2003 | 04 août 2003 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
FARRINGDON ASSOCIATES LTD | 04 août 2003 | 04 août 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
RICHARD WATTS PROPERTIES LIMITED | 04 août 2003 | 04 août 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
PRO-TEX SECURITY SERVICES LIMITED | 31 juil. 2003 | 31 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
CUNNINGHAM PIANO SERVICES LIMITED | 31 juil. 2003 | 31 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
GLENTHORNE HOUSE (EASTBOURNE) LIMITED | 31 juil. 2003 | 31 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BLUEJAY CONSTRUCTION LIMITED | 31 juil. 2003 | 31 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
LONDON & LOTHIAN OVERSEAS (GERMANY) LIMITED | 30 juil. 2003 | 30 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
DAYS OF ASHWELL LIMITED | 30 juil. 2003 | 30 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
A J STANFORD CONSULTANCY LIMITED | 29 juil. 2003 | 29 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
MARTIN JACOB INVESTMENTS LIMITED | 29 juil. 2003 | 29 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
GO LIVE INTERNATIONAL LIMITED | 29 juil. 2003 | 29 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
S. & P. LOMAS LIMITED | 28 juil. 2003 | 28 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
JP AGRONOMY LIMITED | 28 juil. 2003 | 28 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
OLIVIA'S OF SHERINGHAM LIMITED | 28 juil. 2003 | 28 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
PURTILE LIMITED | 28 juil. 2003 | 11 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BLUECROSS HOMECARE LIMITED | 28 juil. 2003 | 04 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
CHESHIRE CAR SALES LTD | 28 juil. 2003 | 28 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
A & S GAS SERVICES LTD | 28 juil. 2003 | 28 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SOHO ROAD HEALTH PLAZA LIMITED | 28 juil. 2003 | 04 déc. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
N PHILLIPS PROPERTY MAINTENANCE & HOME IMPROVEMENTS LIMITED | 28 juil. 2003 | 28 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
CRYSTACIDE PHARMA LIMITED | 28 juil. 2003 | 28 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
KIM WOODROW LIMITED | 28 juil. 2003 | 28 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
PAUL GALBRAITH & SON LIMITED | 25 juil. 2003 | 25 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
WORKWEST LIMITED | 25 juil. 2003 | 20 août 2003 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0