Howard THOMAS - Page 169
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Howard |
Nom de famille | THOMAS |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 7 |
Démissionné | 7852 |
Total | 7859 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTION HYGIENE LIMITED | 15 août 1997 | 15 août 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
LIGHTING AND POWER SOLUTIONS LIMITED | 14 août 1997 | 05 sept. 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
LAPEL (STAFFORD) LIMITED | 13 août 1997 | 13 août 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
INDEPENDENCE HOMES LIMITED | 13 août 1997 | 13 août 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
45-58 VARSITY DRIVE LIMITED | 12 août 1997 | 12 août 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SLEEPEEZEE BEDS LIMITED | 12 août 1997 | 12 août 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
QUEEN THEATRICAL PRODUCTIONS LIMITED | 08 août 1997 | 29 août 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
S.S. SYSTEMS LIMITED | 06 août 1997 | 04 sept. 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BUSINESS SOLUTIONS (QUALITY AND TRAINING) LIMITED | 06 août 1997 | 06 août 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
OXHILL ASSOCIATES LIMITED | 06 août 1997 | 06 août 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
CASTLE PLUMBING & HEATING LIMITED | 04 août 1997 | 04 août 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
FINISHING TOUCHES PORTFOLIO LTD | 01 août 1997 | 01 août 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SOUTHERN PRIMECARE LIMITED | 01 août 1997 | 01 août 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
MILBROOKE PRINTERS LIMITED | 30 juil. 1997 | 08 août 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
FRONTIER TRADING LIMITED | 29 juil. 1997 | 29 juil. 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
M2 COMPUTING LTD | 29 juil. 1997 | 31 juil. 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
YMDDIRIEDOLAETH TYDDYN BACH TRUST CYFYNGEDIG | 28 juil. 1997 | 28 juil. 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
WANDGAS SPORTS AND SOCIAL CLUB LTD | 25 juil. 1997 | 25 juil. 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
JOHN RICHARDS NURSERIES LIMITED | 24 juil. 1997 | 24 juil. 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
ADAPT CARE HOMES LIMITED | 24 juil. 1997 | 24 juil. 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
FAST TRACK REFURBISHMENTS LIMITED | 23 juil. 1997 | 23 juil. 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
MAGISTER LTD | 23 juil. 1997 | 23 juil. 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
S.G. HOLDINGS LIMITED | 21 juil. 1997 | 21 juil. 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
FRESHWATER FISHERIES ADVISORY SERVICES LIMITED | 18 juil. 1997 | 18 juil. 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
QUADWORKS SOFTWARE LIMITED | 17 juil. 1997 | 17 juil. 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
27 SANDRINGHAM ROAD MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 17 juil. 1997 | 17 juil. 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
117 CARSHALTON ROAD RESIDENTS COMPANY LIMITED | 17 juil. 1997 | 17 juil. 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
EMBASSY HOLDINGS LIMITED | 16 juil. 1997 | 16 juil. 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
DAVID LIMITED | 15 juil. 1997 | 15 juil. 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BROADWATER FARM MANAGEMENT (KENT) LIMITED | 11 juil. 1997 | 11 juil. 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
CENTRAL VISIONPLUS LIMITED | 10 juil. 1997 | 26 nov. 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
CLEARVIEW GLAZING LTD | 10 juil. 1997 | 10 juil. 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
HALLINGBURY SPORT HORSE LIMITED | 08 juil. 1997 | 08 juil. 1997 | Active | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
MAJOR MICROS LIMITED | 07 juil. 1997 | 07 juil. 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
ANTON'S CAFE LIMITED | 03 juil. 1997 | 03 juil. 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0