Clifford Donald WING - Page 17
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Clifford |
Deuxième prénom | Donald |
Nom de famille | WING |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 4 |
Inactif | 33 |
Démissionné | 1634 |
Total | 1671 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MABWIN SUPPLEMENTARY SCHOOL | 16 déc. 1997 | 16 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
CALVERLEY PLASTERERS LIMITED | 16 déc. 1997 | 16 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
GOODCOOK LIMITED | 08 déc. 1997 | 16 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
REACT MUSIC PUBLISHING LIMITED | 19 nov. 1997 | 15 déc. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
SINDENS LIMITED | 11 déc. 1997 | 11 déc. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
AZTEC MODELMAKERS LIMITED | 11 déc. 1997 | 11 déc. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
XONY IT CONSULTING LIMITED | 08 déc. 1997 | 11 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
MAXIM PUBLIC RELATIONS LIMITED | 07 nov. 1997 | 10 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
BRICE-BAKER & CO. LIMITED | 09 déc. 1997 | 09 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
WILD LIFE WORLD LIMITED | 05 déc. 1997 | 05 déc. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
14, ST. GEORGE'S DRIVE RESIDENTS CO. LIMITED | 05 déc. 1997 | 05 déc. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
THE LAUNDER CENTRE LIMITED | 05 déc. 1997 | 05 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
LEEMAR DUCTWORK LIMITED | 04 déc. 1997 | 04 déc. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
COOPER & POTTS FLOORING SERVICES LIMITED | 04 déc. 1997 | 04 déc. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
MILLENNIUM CARE (U.K.) LIMITED | 07 nov. 1997 | 03 déc. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
AMERICAN MOTORHOME CLUB UK LIMITED | 03 déc. 1997 | 03 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
TRIPS4 LIMITED | 03 déc. 1997 | 03 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
SAMUELSON FILMS LIMITED | 02 déc. 1997 | 02 déc. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
SOLO EVENTS LIMITED | 02 déc. 1997 | 02 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
DAVIES WOVEN WIRE LIMITED | 27 nov. 1997 | 27 nov. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
WINPLAN (UK) LIMITED | 27 nov. 1997 | 27 nov. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
HEUSTON ENTERPRISES LIMITED | 22 oct. 1997 | 27 nov. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
CORABAR LIMITED | 27 nov. 1997 | 27 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
STONEBRIDGE SMALLHOLDINGS LTD | 22 oct. 1997 | 27 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
POWERGRADE LIMITED | 24 oct. 1997 | 26 nov. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
ABC PUBLISHERS LIMITED | 25 nov. 1997 | 25 nov. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
J.J. DAVIES LIMITED | 25 nov. 1997 | 25 nov. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
THE TEXTILE CENTRE LIMITED | 25 nov. 1997 | 25 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
MUSTERFIELD FARMS LIMITED | 22 oct. 1997 | 24 nov. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
LINCOLN TELESERVICE LIMITED | 21 nov. 1997 | 21 nov. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
CDS JOINERY LIMITED | 19 nov. 1997 | 19 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
MAKING LIGHT WORK LIMITED | 17 nov. 1997 | 17 nov. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
HARTWELL PARTNERSHIP LIMITED | 21 oct. 1997 | 17 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
C-PATH LIMITED | 14 nov. 1997 | 14 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
OPTIMUM CLEANING SERVICES LIMITED | 14 nov. 1997 | 14 nov. 1997 | Dissoute | Acis Acii | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0