Clifford Donald WING - Page 33
Personne physique
| Titre | |
|---|---|
| Prénom | Clifford |
| Deuxième prénom | Donald |
| Nom de famille | WING |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 4 |
| Inactif | 33 |
| Démissionné | 1634 |
| Total | 1671 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCANE TRADING LIMITED | 24 juin 1996 | 24 juin 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| TANNER STILES PUBLISHING LIMITED | 19 juin 1996 | 04 juil. 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| YNS REALISATIONS LIMITED | 19 juin 1996 | 19 juin 1996 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| TSI WORKSPACE LTD | 18 juin 1996 | 01 juil. 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| A.A.C. HOLDINGS LIMITED | 18 juin 1996 | 03 juil. 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| ALEXANDER GAGE OPTICIANS LIMITED | 17 juin 1996 | 17 juin 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| FLOYD ESTATES LIMITED | 14 juin 1996 | 14 juin 1996 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| TAP2BILL LIMITED | 14 juin 1996 | 14 juin 1996 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| LIPOWICZ LIMITED | 11 juin 1996 | 11 juin 1996 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| PRO-TECH SYSTEMS (NORTHERN) LIMITED | 11 juin 1996 | 11 juin 1996 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| EARLYSTART LIMITED | 10 juin 1996 | 25 juin 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| NEARSIDE LIMITED | 10 juin 1996 | 18 juin 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| BESTYEAR LIMITED | 10 juin 1996 | 25 juin 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| CLEARDALE LIMITED | 10 juin 1996 | 17 juin 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| TAMARACK HOLDINGS LIMITED | 10 juin 1996 | 20 juin 1996 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| H.F.I. LIMITED | 04 juin 1996 | 04 juin 1996 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | |
| P.A.A. AVIATION LIMITED | 03 juin 1996 | 03 juin 1996 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| LANDGRASS LIMITED | 03 juin 1996 | 13 juin 1996 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| WEBWEST LIMITED | 03 juin 1996 | 14 juin 1996 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| LATIMER SALES LIMITED | 03 juin 1996 | 18 juin 1996 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| FIRED UP CORPORATION LIMITED | 31 mai 1996 | 31 mai 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| WATTRUS PATTERNS AND MODELS LIMITED | 30 mai 1996 | 30 mai 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| PLUMBLINE LIMITED | 30 mai 1996 | 03 juin 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| P.M. TOOLING LIMITED | 30 mai 1996 | 03 juin 1996 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| NW4 MOTORCYCLES LTD | 29 mai 1996 | 29 mai 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| CUTWEL LIMITED | 23 mai 1996 | 23 mai 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| INGENIC (11 ST THOMAS ST) LTD | 20 mai 1996 | 20 mai 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| BIG CAT PRESS LIMITED | 20 mai 1996 | 20 mai 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| SIMPSON BENDIG LIMITED | 17 mai 1996 | 17 mai 1996 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| SOCCAR LIMITED | 17 mai 1996 | 17 mai 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| ASSOCIATED VALUERS LIMITED | 17 mai 1996 | 17 mai 1996 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| NEW MILLENNIA LIMITED | 03 mai 1996 | 23 mai 1996 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| BENTLEY MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 03 mai 1996 | 23 mai 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| NEWPLAN SHOPFITTING LIMITED | 03 mai 1996 | 03 mai 1996 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| ALTON CARS YORK LTD | 03 mai 1996 | 24 mai 1996 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0