Clifford Donald WING - Page 22
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Clifford |
Deuxième prénom | Donald |
Nom de famille | WING |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 4 |
Inactif | 33 |
Démissionné | 1634 |
Total | 1671 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL STOCK DISTRIBUTORS LIMITED | 11 juin 1997 | 11 juin 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
E.A. LEWIS (ENGINEERING) LIMITED | 23 mai 1997 | 11 juin 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
DUNMAR PACKAGING LIMITED | 11 juin 1997 | 11 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
BUSINESSPARK LIMITED | 01 mai 1997 | 10 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
BROOKDALE PRINTING CO. LIMITED | 22 mai 1997 | 09 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
D.M.S. ENGINEERING LIMITED | 05 juin 1997 | 05 juin 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
HERMES CHARTERING LIMITED | 05 juin 1997 | 05 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
METROPOLIS AV & FX LIMITED | 21 mai 1997 | 04 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
THE TAILORED DESIGN PARTNERSHIP LIMITED | 02 juin 1997 | 02 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
QUANTUM PORTFOLIO LTD | 02 juin 1997 | 02 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
WEBPAC LIMITED | 30 mai 1997 | 30 mai 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
BEARCO TRADING LIMITED | 30 mai 1997 | 30 mai 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
TONIC ASSOCIATES LIMITED | 29 mai 1997 | 29 mai 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
MCHALE WARD ASSOCIATES LIMITED | 29 mai 1997 | 29 mai 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
HOLDPOWER LIMITED | 01 mai 1997 | 28 mai 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
REGIONAL BUILDING CONTROL LIMITED | 27 mai 1997 | 27 mai 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
FULLFLEX LIMITED | 09 mai 1997 | 22 mai 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
M.B. @ N CREDIT SERVICES LIMITED | 21 mai 1997 | 21 mai 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
COMPLETE FACILITIES LIMITED | 21 mai 1997 | 21 mai 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
DAVICS CONSTRUCTION LIMITED | 20 mai 1997 | 20 mai 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
RED OAK INVESTMENTS LIMITED | 20 mai 1997 | 20 mai 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
THE HANBURY COMPANY (STOURBRIDGE) LIMITED | 18 avr. 1997 | 20 mai 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
F.J. WASSELL PROPERTIES LIMITED | 17 avr. 1997 | 20 mai 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
1 FM LIMITED | 20 mai 1997 | 20 mai 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
FIRSTSHOP LIMITED | 01 mai 1997 | 19 mai 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
BROWN ASSOCIATES (EUROPE) LIMITED | 19 mai 1997 | 19 mai 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
IMAGE UK LIMITED | 19 mai 1997 | 19 mai 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
FLEET CAR RENTALS LIMITED | 19 mai 1997 | 19 mai 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
WHITELAM COUNTRY HOMES LIMITED | 01 mai 1997 | 19 mai 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
BUILDTEAM LIMITED | 01 mai 1997 | 19 mai 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
UNITED GRAB HIRE LIMITED | 16 mai 1997 | 16 mai 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
NEWVENTURE LIMITED | 01 mai 1997 | 16 mai 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
SOLVE-IT CONSULTING LIMITED | 16 mai 1997 | 16 mai 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
MALCOLM KAYSER COMPUTER TRAINING LIMITED | 16 mai 1997 | 16 mai 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
MARATHON MAPS LIMITED | 15 mai 1997 | 15 mai 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0