Clifford Donald WING - Page 18
Personne physique
| Titre | |
|---|---|
| Prénom | Clifford |
| Deuxième prénom | Donald |
| Nom de famille | WING |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 4 |
| Inactif | 33 |
| Démissionné | 1634 |
| Total | 1671 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEEMAR DUCTWORK LIMITED | 04 déc. 1997 | 04 déc. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| COOPER & POTTS FLOORING SERVICES LIMITED | 04 déc. 1997 | 04 déc. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| AMERICAN MOTORHOME CLUB UK LIMITED | 03 déc. 1997 | 03 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| TRIPS4 LIMITED | 03 déc. 1997 | 03 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| SOLO EVENTS LIMITED | 02 déc. 1997 | 02 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| SAMUELSON FILMS LIMITED | 02 déc. 1997 | 02 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| DAVIES WOVEN WIRE LIMITED | 27 nov. 1997 | 27 nov. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| CORABAR LIMITED | 27 nov. 1997 | 27 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| MGM TELEVISION (EUROPE) LIMITED | 27 nov. 1997 | 23 déc. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| TRADELEAD LIMITED | 27 nov. 1997 | 12 juin 1998 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| WINPLAN (UK) LIMITED | 27 nov. 1997 | 27 nov. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| ABC PUBLISHERS LIMITED | 25 nov. 1997 | 25 nov. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| THE TEXTILE CENTRE LIMITED | 25 nov. 1997 | 25 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| J.J. DAVIES LIMITED | 25 nov. 1997 | 25 nov. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| HERMES PEOPLE LIMITED | 25 nov. 1997 | 17 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| TIMETABLE LIMITED | 25 nov. 1997 | 19 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| LINCOLN TELESERVICE LIMITED | 21 nov. 1997 | 21 nov. 1997 | Liquidation | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| ENTERPRISE SALES LIMITED | 19 nov. 1997 | 17 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| KAMARA SPORTS LIMITED | 19 nov. 1997 | 09 mars 1998 | Liquidation | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| REACT MUSIC PUBLISHING LIMITED | 19 nov. 1997 | 15 déc. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| CDS JOINERY LIMITED | 19 nov. 1997 | 19 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| MAKING LIGHT WORK LIMITED | 17 nov. 1997 | 17 nov. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| C-PATH LIMITED | 14 nov. 1997 | 14 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| OPTIMUM CLEANING SERVICES LIMITED | 14 nov. 1997 | 14 nov. 1997 | Dissoute | Acis Acii | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | |
| ORION PAX LIMITED | 13 nov. 1997 | 13 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| INFORMATION TECHNOLOGY BUSINESS SOLUTIONS LIMITED | 13 nov. 1997 | 13 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| CONSIDERATE CONSTRUCTORS SCHEME LIMITED | 13 nov. 1997 | 13 nov. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| EUROLINK DESPATCH WORLDWIDE LIMITED | 13 nov. 1997 | 13 nov. 1997 | Liquidation | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| D.C. MOULDINGS LIMITED | 11 nov. 1997 | 11 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| MAXIM PUBLIC RELATIONS LIMITED | 07 nov. 1997 | 10 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| CIRENCESTER VEHICLE SERVICES LIMITED | 07 nov. 1997 | 13 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| MILLENNIUM CARE (U.K.) LIMITED | 07 nov. 1997 | 03 déc. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| PETER HOLMES HAULAGE LIMITED | 07 nov. 1997 | 07 nov. 1997 | Liquidation | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| CARNIVAL PYROTECHNICS LIMITED | 04 nov. 1997 | 04 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| ASTEC TM LTD. | 03 nov. 1997 | 03 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0