Clifford Donald WING - Page 27
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Clifford |
Deuxième prénom | Donald |
Nom de famille | WING |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 4 |
Inactif | 33 |
Démissionné | 1634 |
Total | 1671 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR DESIGNS & MARKETING LIMITED | 28 janv. 1997 | 28 janv. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
THE ACTIVE BRANDING CONSULTANCY LIMITED | 28 janv. 1997 | 28 janv. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
GRANDPLACE LIMITED | 30 déc. 1996 | 28 janv. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
UNIQUE SEAFOOD LIMITED | 27 janv. 1997 | 27 janv. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
HOWARTH BROTHERS HAULAGE LIMITED | 24 janv. 1997 | 24 janv. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
HOWARTH BROTHERS PROPERTIES LIMITED | 24 janv. 1997 | 24 janv. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
FREEPORT VILLAGE BRAINTREE LIMITED | 20 déc. 1996 | 24 janv. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
COLSUR MATERIALS LIMITED | 22 janv. 1997 | 22 janv. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
HOLIDAYS IN THE UK LIMITED | 22 janv. 1997 | 22 janv. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
HOMETALENT LIMITED | 20 déc. 1996 | 22 janv. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
PAVILION HOMES (SUSSEX) LIMITED | 21 janv. 1997 | 21 janv. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
GOLDCREST DEVELOPMENTS (CHILTERNS) LIMITED | 18 déc. 1996 | 16 janv. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
THORPE COURT FREEHOLD LIMITED | 14 janv. 1997 | 14 janv. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
BLACK DOG FILMS LIMITED | 14 janv. 1997 | 14 janv. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
BARNETT PROPERTIES LIMITED | 17 déc. 1996 | 13 janv. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
BARNETT PROPERTIES (HOLDINGS) LIMITED | 30 déc. 1996 | 13 janv. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
BARNETT INDUSTRIES (HOLDINGS) LIMITED | 17 déc. 1996 | 13 janv. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
YK CONSULTING LIMITED | 09 janv. 1997 | 09 janv. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
THE CLASSIC HOME COMPANY LIMITED | 09 janv. 1997 | 09 janv. 1997 | Liquidation | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
NORTHERN REFRIGERATION WHOLESALE LIMITED | 27 nov. 1996 | 08 janv. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
ACTIONWELL LIMITED | 27 nov. 1996 | 07 janv. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
SOUNDSURE LIMITED | 27 nov. 1996 | 06 janv. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
MONTANA BAKERY LIMITED | 02 janv. 1997 | 02 janv. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
PLAXTOL MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 02 janv. 1997 | 02 janv. 1997 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
DAVID LOWE MUSIC LIMITED | 30 déc. 1996 | 30 déc. 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
FOXLAND ESTATES LTD | 30 déc. 1996 | 30 déc. 1996 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
ULYSSES ENGINEERING DESIGN AND SOFTWARE LTD | 24 déc. 1996 | 24 déc. 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
N.J. ELECTRICALS LIMITED | 24 déc. 1996 | 24 déc. 1996 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
WORKWELL LIMITED | 27 nov. 1996 | 23 déc. 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
THE PARLIAMENT GROUP LTD. | 20 déc. 1996 | 20 déc. 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
THERMO ONIX LIMITED | 26 nov. 1996 | 18 déc. 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
CAC LIMITED | 26 nov. 1996 | 18 déc. 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
THERMO MEASUREMENT LTD | 26 nov. 1996 | 18 déc. 1996 | Dissoute | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
MILLENNIUM ESTATES SERVICES LIMITED | 17 déc. 1996 | 17 déc. 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
WARNERS GROUP HOLDINGS LIMITED | 17 déc. 1996 | 17 déc. 1996 | Active | Secrétaire | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0