Dorothy May GRAEME - Pagina 227
Persona fisica
Titolo | |
---|---|
Nome | Dorothy |
Secondo nome | May |
Cognome | GRAEME |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 0 |
Dimesso | 9882 |
Totale | 9882 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BINA GARDENS FREEHOLD LIMITED | 20 feb 1997 | 20 feb 1997 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
JOSEPH M. LIMITED | 20 feb 1997 | 20 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
JOHN D. LANE (STRUCTURES) LIMITED | 20 feb 1997 | 20 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MILLENNIUM COLLECTABLES LIMITED | 16 dic 1996 | 19 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MILLENNIUM WINDOWS CHESHIRE LIMITED | 18 feb 1997 | 18 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
OAKLEY TRAVEL LIMITED | 18 feb 1997 | 18 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CARD SPECIALIST SERVICES LIMITED | 18 feb 1997 | 18 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CIRCUSSTAR LIMITED | 24 gen 1997 | 17 feb 1997 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
EVENTMASTERS LIMITED | 14 feb 1997 | 14 feb 1997 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BANSTEAD LIMITED | 05 feb 1997 | 14 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
H.M.E. DEVELOPMENTS LIMITED | 12 feb 1997 | 12 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SOLIDS HANDLING AND PROCESS ENGINEERING LIMITED | 12 feb 1997 | 12 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
D.C. PLASTIC HANDRAILS LIMITED | 12 feb 1997 | 12 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ELLISON COURT LIMITED | 12 feb 1997 | 12 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
JADE ENTERPRISES (U.K.) LIMITED | 12 feb 1997 | 12 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
NORTON MOTOR COMPANY (TAUNTON) LIMITED | 11 feb 1997 | 11 feb 1997 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
I. S. GROUP PROJECTS LIMITED | 11 feb 1997 | 11 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
I.S. GROUP SUPPORT LIMITED | 11 feb 1997 | 11 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THE IMPERIAL SECURITY GROUP LIMITED | 11 feb 1997 | 11 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BABIES 'R' US LIMITED | 11 feb 1997 | 11 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CANAL INDUSTRIAL PARK MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 07 feb 1997 | 07 feb 1997 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
EU-LOGYSTICS LIMITED | 07 feb 1997 | 07 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CARLTONS BUSINESS LIMITED | 06 feb 1997 | 06 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
M. RANDALL PAINTING & DECORATING LIMITED | 06 feb 1997 | 06 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CONCEPT PLASTICS LIMITED | 05 feb 1997 | 05 feb 1997 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BAILEY AND BIRCH LIMITED | 05 feb 1997 | 05 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SECEURO LIMITED | 05 feb 1997 | 05 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THE BODY ROCKERS LTD | 04 feb 1997 | 04 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
NETSITE LIMITED | 04 feb 1997 | 04 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CARBONLITE SOLAR LIMITED | 31 gen 1997 | 03 feb 1997 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ENCHANTICA LIMITED | 18 dic 1996 | 03 feb 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SURF THE EARTH LIMITED | 26 set 1996 | 30 gen 1997 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ABSOLUTE CAD LIMITED | 30 gen 1997 | 30 gen 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
NORTHERNSPARK LIMITED | 15 nov 1996 | 28 gen 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PAPERMAZE LIMITED | 25 ott 1996 | 28 gen 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Precedente23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Successivo
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0