Dorothy May GRAEME - Pagina 274
Persona fisica
Titolo | |
---|---|
Nome | Dorothy |
Secondo nome | May |
Cognome | GRAEME |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 0 |
Dimesso | 9882 |
Totale | 9882 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABLE & WIRE TECHNICAL SERVICES LTD | 09 nov 1992 | 09 nov 1992 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AQUAGLIDE LIMITED | 23 lug 1992 | 05 nov 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
KINIKI LIMITED | 14 ago 1992 | 04 nov 1992 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
IMARIPLAN LIMITED | 12 ott 1992 | 04 nov 1992 | Liquidazione | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SHARP IT SERVICES (UK) LIMITED | 03 nov 1992 | 03 nov 1992 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PROFESSIONAL MARKETING LIMITED | 07 set 1992 | 03 nov 1992 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
D'ARCY & EVEREST LIMITED | 02 nov 1992 | 02 nov 1992 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THE FOOTBED CLINIC LIMITED | 02 nov 1992 | 02 nov 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CUZN DESIGN LIMITED | 27 lug 1992 | 30 ott 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
W.B. TIDEY (FINANCIAL SERVICES) LTD. | 29 ott 1992 | 29 ott 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LONDONSPIRIT LIMITED | 09 set 1992 | 28 ott 1992 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GEE WIZ TV LIMITED | 28 ott 1992 | 28 ott 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
STARCONNECT LIMITED | 21 lug 1992 | 27 ott 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DASH COURIERS (KENT) LIMITED | 23 ott 1992 | 23 ott 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DEVONBELL LIMITED | 15 set 1992 | 21 ott 1992 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SKYLINE PROJECTS LIMITED | 19 ott 1992 | 19 ott 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MANAS STUDIO LTD | 09 dic 1992 | 16 ott 1992 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AUTOREPAIRS LIMITED | 13 ott 1992 | 16 ott 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
K.C. DESIGN LIMITED | 15 ott 1992 | 15 ott 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
COMPLETE SEAL WINDOWS (NORTH EAST) LIMITED | 15 ott 1992 | 15 ott 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
N.C. CRANES AND STRUCTURES LIMITED | 03 set 1992 | 14 ott 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TRANS ANGLO MARINE LIMITED | 13 ott 1992 | 13 ott 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WAVELENGTH ELECTRONICS LIMITED | 12 ott 1992 | 12 ott 1992 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
STANMORE CONTRACTORS LIMITED | 09 ott 1992 | 12 ott 1992 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THOMPSONS ELECTRICAL (WHOLESALE) LIMITED | 12 ott 1992 | 12 ott 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CLOSE GRANGER GRAY & WILKIN CONSULTANCY LIMITED | 09 ott 1992 | 09 ott 1992 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DRYDEN SMITH PRINT LIMITED | 26 mag 1992 | 08 ott 1992 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GPC PLUMBING & HEATING SERVICES LIMITED | 03 ago 1992 | 05 ott 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BRADBURY GROUP LIMITED | 02 ott 1992 | 02 ott 1992 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DAWSONWAY LIMITED | 12 giu 1992 | 02 ott 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CITY TANGENT INTERIORS LIMITED | 30 set 1992 | 30 set 1992 | Liquidazione | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
UP+RUNNING (HYDE, 1992) LIMITED | 19 ago 1992 | 29 set 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AXIOMCROFT LIMITED | 12 ago 1992 | 28 set 1992 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GALLERY FIFTY FIVE LIMITED | 25 set 1992 | 25 set 1992 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HARLEYBELL LIMITED | 12 ago 1992 | 24 set 1992 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Precedente23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Successivo
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0