Dorothy May GRAEME - Pagina 86
Persona fisica
Titolo | |
---|---|
Nome | Dorothy |
Secondo nome | May |
Cognome | GRAEME |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 0 |
Dimesso | 9882 |
Totale | 9882 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL REDDY PARTNERSHIPS LIMITED | 10 gen 2003 | 10 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MICHAEL JAMES INSURANCE SERVICES LTD | 10 gen 2003 | 10 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AERODROME PIT STOP LIMITED | 10 gen 2003 | 10 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FLOOR HEATECH LIMITED | 02 gen 2003 | 10 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ROSEMEAD ENTERPRISES LIMITED | 30 dic 2002 | 10 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
JOH TAXATION LIMITED | 08 gen 2003 | 08 gen 2003 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
EUROPA AUTO MOVEMENTS LIMITED | 08 gen 2003 | 08 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ANDY CALVERT GARDENING LTD | 08 gen 2003 | 08 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DISCOVERY GARAGE LIMITED | 08 gen 2003 | 08 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TWENTY FOUR 7 CARE SERVICES LTD | 08 gen 2003 | 08 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SWALES & CATTERICK LIMITED | 08 gen 2003 | 08 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TODDLE IN DAY NURSERIES LIMITED | 08 gen 2003 | 08 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
RICHARDSON HEATING & ELECTRICAL SERVICES LIMITED | 07 gen 2003 | 07 gen 2003 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THE KING PRAWN COMPANY LIMITED | 07 gen 2003 | 07 gen 2003 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MALTBY ACCOUNTANCY SERVICES LIMITED | 07 gen 2003 | 07 gen 2003 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HOLMEFIELD GARAGE LIMITED | 29 nov 2002 | 07 gen 2003 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
OCEAN CONSULTANCY SERVICES LIMITED | 07 gen 2003 | 07 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LEDA ENGINEERING SERVICES LIMITED | 07 gen 2003 | 07 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
COUNTRY STYLE CATERING LIMITED | 07 gen 2003 | 07 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AURORA 2 LTD | 07 gen 2003 | 07 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WISE INC LIMITED | 07 gen 2003 | 07 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TERMODECK INTERNATIONAL LIMITED | 07 gen 2003 | 07 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ADN EUROPE LIMITED | 24 ott 2002 | 07 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
L.M. ELECTRICAL LIMITED | 06 gen 2003 | 06 gen 2003 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
R J KAY LIMITED | 06 gen 2003 | 06 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
P & JD PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | 06 gen 2003 | 06 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PRO-ALLIANCE SERVICES LIMITED | 18 ott 2002 | 06 gen 2003 | Liquidazione | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DETECH EUROPE LIMITED | 03 gen 2003 | 03 gen 2003 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
D R PRICE ASSOCIATES LIMITED | 17 dic 2002 | 03 gen 2003 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CLIFFORD ELMER BOOKS LTD | 03 gen 2003 | 03 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
JK DRIVING SCHOOL LIMITED | 03 gen 2003 | 03 gen 2003 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
P & S DEVELOPERS LIMITED | 02 gen 2003 | 02 gen 2003 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DAVID ASHWORTH LIMITED | 02 gen 2003 | 02 gen 2003 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PIXELS LIMITED | 02 gen 2003 | 02 gen 2003 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TOPSOURCE WORLDWIDE (UK) LTD | 02 gen 2003 | 02 gen 2003 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Precedente23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Successivo
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0