• Dati
  • Gran Bretagna
  • Aziende
  • Cerca aziende
  • Sanzioni
  • Cerca sanzioni
  • Dorothy May GRAEME - Pagina 263

    Persona fisica

    Titolo
    NomeDorothy
    Secondo nomeMay
    CognomeGRAEME
    È un dirigente societarioNo
    Incarichi
    Attivo0
    Inattivo0
    Dimesso9882
    Totale9882

    Incarichi

    Incarichi assegnati
    Nominato aData di nominaData di dimissioniStato della societàProfessioneRuoloIndirizzoPaese di residenzaNazionalità
    ARKLE AUTOPARTS LIMITED10 mar 199410 mar 1994ScioltaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    A E M STUDIO LIMITED10 mar 199410 mar 1994ScioltaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    R.S.M. CARPENTRY LIMITED08 mar 199408 mar 1994AttivaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    REACTION RECORDS LIMITED07 mar 199407 mar 1994ScioltaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HBM LIMITED05 mar 199305 mar 1994AttivaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    THE PORTABLE CABIN SHOP LIMITED04 mar 199404 mar 1994ScioltaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SUSSEX SERVICES LIMITED04 mar 199404 mar 1994ScioltaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ASHRIDGE CONSTRUCTION (DEVELOPMENTS) LIMITED21 feb 199404 mar 1994ScioltaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    WILLOW COMPUTER SERVICES LIMITED03 mar 199403 mar 1994AttivaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    STANDISH GOLF CENTRE LIMITED03 mar 199403 mar 1994ScioltaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    P.C.P. (NORTH WEST) LIMITED02 mar 199403 mar 1994ScioltaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HOMESURE WINDOWS LIMITED01 mar 199401 mar 1994ScioltaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    JENNINGS & KENT LIMITED01 mar 199401 mar 1994LiquidazioneSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    EPISODE TWO LTD28 feb 199428 feb 1994AttivaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HICKELTOWN LIMITED22 feb 199425 feb 1994ScioltaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    RICKARD HEATING SUPPLIES LIMITED25 feb 199425 feb 1994LiquidazioneSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    PROFILE CONSTRUCTION CONSULTANTS LIMITED24 feb 199424 feb 1994AttivaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ROBINSON JACKSON LTD24 feb 199424 feb 1994AttivaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MISUS RESOURCES LIMITED24 feb 199424 feb 1994ScioltaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BELMORE ESTATES LIMITED22 feb 199422 feb 1994AttivaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HOOBROOK HOLDINGS LIMITED14 feb 199422 feb 1994AttivaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SPENVALE LIMITED05 gen 199422 feb 1994AttivaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    NESTOR ELECTRONICS LIMITED21 feb 199421 feb 1994AttivaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    G. & G. PUMP SERVICES LIMITED21 feb 199421 feb 1994AttivaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    T.P.S. CONSULTING INTERNATIONAL LIMITED21 feb 199421 feb 1994AttivaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    TAYWEST CONTROL SYSTEMS LIMITED09 feb 199421 feb 1994ScioltaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ALLOY STOCK LIMITED17 feb 199417 feb 1994AttivaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    A. SEATON LAUNDERETTE SERVICING LIMITED17 feb 199417 feb 1994ScioltaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    P.A. FREIGHT SERVICES (LONDON) LIMITED17 feb 199417 feb 1994ScioltaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    S & T FULLERS BUILDERS LIMITED04 feb 199416 feb 1994ScioltaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BISHOPDALE LIMITED13 gen 199415 feb 1994ScioltaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    RLF MORGAN DEVEY LIMITED14 feb 199414 feb 1994ScioltaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BOILER SPARES INTERNATIONAL LIMITED14 feb 199414 feb 1994ScioltaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MEADOW FEEDS LIMITED26 gen 199414 feb 1994ScioltaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CARD LINE GREETINGS LIMITED11 feb 199411 feb 1994ScioltaSegretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0