Dorothy May GRAEME - Pagina 244
Persona fisica
Titolo | |
---|---|
Nome | Dorothy |
Secondo nome | May |
Cognome | GRAEME |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 0 |
Dimesso | 9882 |
Totale | 9882 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISM CONSULTANCY LTD | 30 nov 1995 | 30 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SOUTH WEST BUILDING & MAINTENANCE LIMITED | 29 nov 1995 | 29 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
IRISH GROUPAGE SERVICES LIMITED | 29 nov 1995 | 29 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LG 2011 LIMITED | 29 nov 1995 | 29 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MULTIFIRE GROUP HOLDINGS LIMITED | 29 nov 1995 | 29 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
QMS QUALITY & MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 29 nov 1995 | 29 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PROHIRE SOFTWARE LIMITED | 28 nov 1995 | 28 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
M.J. HALLISSEY LIMITED | 27 nov 1995 | 27 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AUSMIG LIMITED | 24 nov 1995 | 24 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
D.D.M.C. LIMITED | 23 nov 1995 | 23 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CLADDEX LTD | 23 nov 1995 | 23 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
UNIQUE FITNESS LIMITED | 23 nov 1995 | 23 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ALPHA PACKAGING (UK) LIMITED | 23 nov 1995 | 23 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GROSVENOR FACILITIES MANAGEMENT LIMITED | 09 ago 1995 | 21 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ALBATROSS HOLDINGS LIMITED | 20 nov 1995 | 20 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TRANSGLOBAL FOODS RETAIL LIMITED | 20 nov 1995 | 20 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WHOLESALE PLASTICS WINDOWS & CONSERVATORIES LIMITED | 13 ott 1995 | 20 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FERNGALE LIMITED | 04 ago 1995 | 17 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
N.Y.F.R. LIMITED | 18 ago 1995 | 16 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DIAMOND LETTING & PROPERTY MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 27 ott 1995 | 15 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
P. CHALK LIMITED | 14 nov 1995 | 14 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SUNRISESTAR LIMITED | 23 ott 1995 | 14 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GLEBE FARM (EXPORTS) LIMITED | 14 nov 1995 | 14 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DAVID IAN FURNITURE LIMITED | 08 set 1995 | 13 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CENTROMED INTERNATIONAL LIMITED | 17 lug 1995 | 13 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CLARIA HEADSETS LIMITED | 13 nov 1995 | 13 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LANSDOWNE LAUNDERETTE LIMITED | 13 nov 1995 | 13 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BESTBOOTS LIMITED | 10 nov 1995 | 10 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
A1 WELDING & ERECTION SERVICES LIMITED | 10 nov 1995 | 10 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BADDERTON LIMITED | 03 nov 1995 | 10 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TRANSGLOBAL FOODSERVICE LIMITED | 09 nov 1995 | 09 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HELENA HAEMOSTASIS SYSTEMS LIMITED | 08 nov 1995 | 08 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
A.M.J. PROPERTIES LIMITED | 08 nov 1995 | 08 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PERFUME PLUS LIMITED | 06 nov 1995 | 06 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ALG CONSULTING LTD | 30 ott 1995 | 06 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Precedente23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Successivo
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0