Bibi Rahima ALLY - Pagina 28
Persona fisica
Titolo | |
---|---|
Nome | Bibi |
Secondo nome | Rahima |
Cognome | ALLY |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 153 |
Dimesso | 1045 |
Totale | 1198 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCKRUP HALL HOTEL LIMITED | 21 gen 1997 | 05 feb 1997 | Attiva | Segretario | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | British | ||
ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED | 10 gen 1997 | 27 gen 1997 | Sciolta | Segretario | Norwich Street EC4A 1BD London 10 | British | ||
GNS PROPERTY SERVICES LIMITED | 19 dic 1996 | 31 dic 1996 | Sciolta | Segretario | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | British | ||
OXOID INTERNATIONAL LIMITED | 10 dic 1996 | 30 dic 1996 | Attiva | Company Director | Amministratore | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | United Kingdom | British |
OXOID LIMITED | 09 dic 1996 | 30 dic 1996 | Attiva | Company Director | Amministratore | Norwich Street EC4A 1BD London 10 | United Kingdom | British |
OXOID HOLDINGS LIMITED | 09 dic 1996 | 30 dic 1996 | Attiva | Company Director | Amministratore | Norwich Street EC4A 1BD London 10 | United Kingdom | British |
WPP DC PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED | 21 nov 1996 | 20 dic 1996 | Attiva | Segretario | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | British | ||
PORTSMOUTH HARBOUR RENAISSANCE LIMITED | 05 dic 1996 | 19 dic 1996 | Attiva | Segretario | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | British | ||
AIR PLANTS HEATING LIMITED | 10 dic 1996 | 17 dic 1996 | Attiva | Company Director | Amministratore | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | United Kingdom | British |
AIR PLANTS DUST EXTRACTION LIMITED | 10 dic 1996 | 17 dic 1996 | Attiva | Company Director | Amministratore | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | United Kingdom | British |
KINGSPAN METL-CON LIMITED | 15 ott 1996 | 09 dic 1996 | Attiva | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | ||
C. CZARNIKOW LIMITED | 18 giu 1996 | 17 ott 1996 | Attiva | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | ||
OMFS COMPANY 4 LIMITED | 13 giu 1996 | 16 lug 1996 | Sciolta | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | ||
TAYLOR & FRANCIS BOOKS LIMITED | 18 giu 1996 | 28 giu 1996 | Attiva | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | ||
CLE RESIDENTIAL LIMITED | 11 giu 1996 | 14 giu 1996 | Sciolta | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | ||
ADDIS LIMITED | 07 giu 1996 | 12 giu 1996 | Attiva | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | ||
IQVIA IES UK LIMITED | 02 feb 1996 | 28 feb 1996 | Attiva | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | ||
CZARSUGAR LIMITED | 22 nov 1993 | 01 feb 1996 | Sciolta | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | ||
NORTEK (UK) LIMITED | 25 mag 1995 | 05 ott 1995 | Attiva | Company Secretary | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | |
CHELWOOD GROUP | 24 feb 1995 | 18 set 1995 | Liquidazione | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | ||
MELBOURNE GROUP LIMITED | 27 mar 1995 | 25 ago 1995 | Sciolta | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | ||
INTERNATIONAL PRESENTATIONS LIMITED | 25 mag 1995 | 12 lug 1995 | Sciolta | Company Director | Amministratore | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | |
PERI-DENT LIMITED | 13 dic 1993 | 10 lug 1995 | Attiva | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | ||
THE BRICK BUSINESS LIMITED | 01 mar 1995 | 15 giu 1995 | Liquidazione | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | ||
DIGITRON INSTRUMENTATION LIMITED | 31 mar 1995 | 31 mag 1995 | Sciolta | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | ||
ADVANCED ELECTRONIC TECHNOLOGIES LTD. | 31 mar 1995 | 31 mag 1995 | Sciolta | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | ||
CADWEB LIMITED | 21 apr 1995 | 27 apr 1995 | Sciolta | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | ||
AOCI NEW LIMITED | 13 apr 1995 | 27 apr 1995 | Sciolta | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | ||
THAMES VALLEY POWER LIMITED | 29 mar 1995 | 31 mar 1995 | Sciolta | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | ||
WG ACCESS LIMITED | 16 feb 1995 | 07 mar 1995 | Sciolta | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | ||
BIRCHDALE PROPERTIES LIMITED | 08 nov 1994 | 07 mar 1995 | Sciolta | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | ||
MARK BIRLEY (FOR MEN) LIMITED | 15 dic 1994 | 22 feb 1995 | Attiva | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | ||
ST ANDREWS COURT THAME LIMITED | 27 giu 1994 | 10 gen 1995 | Sciolta | Company Director | Amministratore | Norwich Street EC4A 1BD London 10 | United Kingdom | British |
ST ANDREWS COURT THAME LIMITED | 27 giu 1994 | 10 gen 1995 | Sciolta | Company Director | Segretario | Norwich Street EC4A 1BD London 10 | British | |
CLINICAL & ANALYTICAL SERVICE SOLUTIONS LIMITED | 06 ott 1994 | 19 ott 1994 | Sciolta | Company Director | Amministratore | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0