• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Dorothy May GRAEME - Página 119

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeDorothy
    Segundo NomeMay
    Último NomeGRAEME
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo0
    Renunciado9882
    Total9882

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    RGL (NORTHERN) LIMITED23/04/200223/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BRAIN COUNTRY HOMES LIMITED23/04/200223/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    EUROPEAN HEALTH PARTNERSHIP LIMITED12/03/200223/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    OAKHEART TECHNOLOGY LIMITED18/02/200223/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    INTEGRATED CONTROL UTILITIES LIMITED05/04/200222/04/2002AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    NIGHTINGALE CONTRACTORS LIMITED05/04/200222/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    THE FLOWER TAXI LIMITED19/04/200219/04/2002AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    REDCASTLE CRM LIMITED19/04/200219/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    NIGHTINGALE LOGISTICS LIMITED11/04/200219/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    PROCESS PLANT SERVICES LIMITED18/04/200218/04/2002AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    PRIVETT INTERNATIONAL LIMITED18/04/200218/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HILLTOP STANLEY ROAD MANAGEMENT LIMITED18/04/200218/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    H.F.S. TARPORLEY LIMITED17/04/200217/04/2002AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    I & A HOLDINGS LIMITED17/04/200217/04/2002AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CULCHETH CAR SPARES LIMITED17/04/200217/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MITFORD INVESTMENTS LIMITED16/04/200216/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    STARBRIGHT SOLUTIONS LIMITED11/02/200216/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    DENT PERFECT LIMITED06/02/200215/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    GOLDENGATE ASSOCIATES LIMITED27/02/200212/04/2002AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    M F SOLUTIONS (NORTH WEST) LIMITED08/02/200212/04/2002AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    DECENT LIMITED07/02/200212/04/2002AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    M F LOGISTICS (UK) LIMITED04/02/200212/04/2002AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    AISLABY STONE LIMITED11/04/200211/04/2002AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    JULIAN DALTON LIMITED11/04/200211/04/2002AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    THIS IS EMBRACE LIMITED31/01/200211/04/2002AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CENTURION ELECTRICAL SERVICES LIMITED11/04/200211/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SEDULOUS LIMITED11/04/200211/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    STUDIO 3 & LABEL TECHNOLOGY LIMITED11/04/200211/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    C.K. TSUI COMPANY LIMITED25/02/200211/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SILCOCK BUILDERS LIMITED10/04/200210/04/2002AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HAYLE PARK LIVERY LIMITED05/04/200210/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    PACE MARKETING (UK) LIMITED14/02/200210/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    AARON P STONE LIMITED28/01/200210/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    COPPERFIELD LOGISTICS LIMITED25/01/200210/04/2002DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SWINBURNE HORTICULTURAL SERVICES LIMITED27/02/200209/04/2002AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0