• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Dorothy May GRAEME - Página 273

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeDorothy
    Segundo NomeMay
    Último NomeGRAEME
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo0
    Renunciado9882
    Total9882

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    THE BELVEDERE PRIVATE CLINIC LIMITED18/01/199318/01/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CARDY CONSTRUCTION LIMITED15/01/199315/01/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    STYAL MEAT COMPANY LIMITED08/01/199312/01/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    PLANT TEST SERVICES LIMITED06/01/199306/01/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    TRUCKBUSTERS UK LTD04/01/199304/01/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BAY CLASS YACHTS LIMITED04/01/199304/01/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HAMPTONLINE LIMITED09/11/199231/12/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CARILLION RICHARDSON DEVELOPMENTS LIMITED04/11/199231/12/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    PRT (JUNCTION 28) LIMITED21/10/199231/12/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HYNEX (KIDDERMINSTER) LIMITED24/12/199224/12/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CONFILL (MIDLANDS) LIMITED12/11/199224/12/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    COTTESLOE PROPERTIES LIMITED23/12/199223/12/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    TOMEL DESIGN (COVENTRY) LIMITED23/12/199223/12/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    OLDBURY BUSINESS ASSOCIATES LIMITED28/10/199223/12/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    TARION COMMUNICATION SERVICES LTD.22/12/199222/12/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    PHYTHIANS (CRONTON) LIMITED18/12/199218/12/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BOND FOSTER ASSOCIATES LIMITED18/12/199218/12/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SALESLEASE PURCHASE LIMITED17/12/199217/12/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ALLEN CHARLTON LIMITED16/12/199216/12/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ROGERS CONTRACTS LIMITED17/11/199216/12/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ENERGYCARE INSULATIONS LIMITED16/12/199216/12/1992LiquidaçãoSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BLYTH VALLEY GARAGES LIMITED14/12/199214/12/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BLAIR ELECTRICAL LIMITED13/10/199211/12/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    FASHION INVESTMENT PROPERTY LIMITED08/12/199208/12/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    THEOBALDS LIMITED16/10/199204/12/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    LIMB SHIPPING SERVICES (HUMBERSIDE) LIMITED09/11/199230/11/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    DAVY LIVER GROUP LIMITED27/11/199227/11/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BREWERY INNS LTD26/11/199226/11/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MANOR RESOURCES LIMITED24/11/199224/11/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    URATHON EUROPE LIMITED23/11/199223/11/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ENCOUNTERS LIMITED23/11/199223/11/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    RIGIDINSTANT LIMITED23/11/199223/11/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HOBSON HEALTH (NORTHWICH) LIMITED20/11/199220/11/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    EDDY WHITE LIGHTING LIMITED19/11/199219/11/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    PITCHFORD HALL LIMITED17/11/199217/11/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0