• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Dorothy May GRAEME - Página 204

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeDorothy
    Segundo NomeMay
    Último NomeGRAEME
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo0
    Renunciado9882
    Total9882

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    P & P PLUMBING AND HEATING INSTALLATIONS LIMITED23/07/199823/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    NEW TECH GLOBAL SERVICES LTD23/07/199823/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CTS COMMENTARY LIMITED23/07/199823/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    KINGDOM BUSINESS MINISTRY ASSOCIATES LIMITED23/07/199823/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    S.C. FARLEY ELECTRICAL LIMITED23/07/199823/07/1998Acordo voluntárioSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SKB ACCOUNTANTS LIMITED21/07/199821/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CONCRETE GLOBAL U.K. LIMITED21/07/199821/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MOORDALE PROPERTIES LIMITED19/06/199821/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SOLUTION SEEKERS LIMITED17/07/199820/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SPORTSPHONE LIMITED17/07/199817/07/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HEARTLAND GROUP LIMITED17/07/199817/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    JOE PUBLIC STAFF INCENTIVES LIMITED17/07/199817/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    INNOVATIVE FINANCIAL SOLUTIONS LIMITED17/07/199817/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    WATERGATE (LEEDS) LIMITED17/07/199817/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MICHAEL SEHGAL PROPERTY COMPANY LIMITED16/07/199816/07/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    1ST ASSURED LIMITED16/07/199816/07/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HEATTREAT LIMITED16/07/199816/07/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SERRANO (I.T.) LIMITED16/07/199816/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HEARTLAND (MIDLANDS) LIMITED16/07/199816/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    PHOENIX GAS FIRES LIMITED16/07/199816/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BLACK'S SALONS LIMITED01/07/199816/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BETSHAM PARK CORNER MANAGEMENT LIMITED15/07/199815/07/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SOLOMONS CARPETS LIMITED15/07/199815/07/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    KINGSDELL PROPERTIES LIMITED16/06/199815/07/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    1ST CHOICE GLAZING AND MAINTENANCE LIMITED15/07/199815/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MILLGATE ENTERPRISES LIMITED29/06/199815/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MEMS ENGINEERING LIMITED14/07/199814/07/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    B & H BUILDINGS LIMITED14/07/199814/07/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    LISTONDALE LIMITED14/07/199814/07/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BREWERY PLASTICS LIMITED02/07/199814/07/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HEITMANN PROPERTIES LIMITED14/07/199814/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    R & D CONCEPTS LIMITED14/07/199814/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CONSULTANTS @ WORK LIMITED14/07/199814/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CATERITE OF TROWBRIDGE LIMITED14/07/199814/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    LAKEVIEW ASSOCIATES LIMITED04/06/199814/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0