• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Dorothy May GRAEME - Página 78

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeDorothy
    Segundo NomeMay
    Último NomeGRAEME
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo0
    Renunciado9882
    Total9882

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    COPLEY DEVELOPMENTS LIMITED27/02/200327/02/2003DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    M.A.N. CONTRACTING SERVICES LIMITED27/02/200327/02/2003DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SOUTH EAST NETTING LIMITED27/02/200327/02/2003LiquidaçãoSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    KDM PRINT LIMITED26/02/200326/02/2003AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SCYLLA LIMITED26/02/200326/02/2003AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ANDYS WINDOW CLEANING SERVICES LIMITED26/02/200326/02/2003AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    TYLER-PARKES PUBLIC SECTOR LIMITED26/02/200326/02/2003AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ABC DIGITAL CAMERAS LIMITED26/02/200326/02/2003DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    LJ LTD26/02/200326/02/2003DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    A1 MEN & VANS LIMITED26/02/200326/02/2003DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SHOW MARQUE LIMITED26/02/200326/02/2003DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ROCKFIELD ESTATES LIMITED30/01/200326/02/2003DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    FISHER & COMPANY LIMITED25/02/200325/02/2003AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CJ MOTORS LONDON LIMITED25/02/200325/02/2003AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CAPITAL CONTRACT SERVICES LIMITED25/02/200325/02/2003AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ROCKY & MAZ'S LIMITED25/02/200325/02/2003AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MOSELEY CARE LIMITED25/02/200325/02/2003AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    LESLEY'S FLORIST LIMITED25/02/200325/02/2003AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    PHILPRINT (SCARBOROUGH) LTD25/02/200325/02/2003AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    INSCAPE BUILDING PRODUCTS LTD25/02/200325/02/2003DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    COULSON EXECUTIVE RESOURCING LTD25/02/200325/02/2003DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    WORXCLEAN LIMITED25/02/200325/02/2003DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CARNEY COMMUNICATIONS LIMITED25/02/200325/02/2003DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ARTYFECT LIMITED25/02/200325/02/2003DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    C & M CONSTRUCTION (UK) LIMITED25/02/200325/02/2003DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ABRYN LTD25/02/200325/02/2003DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    TECHNIC DESIGNS LIMITED25/02/200325/02/2003DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CHRISTAKIS HAIR CONSULTANTS LIMITED25/02/200325/02/2003DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HANNANT & SONS (WOOD FINISHES) LTD25/02/200325/02/2003DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    QUARTZLAND LIMITED20/02/200324/02/2003AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ESSENTIAL VENTURES LIMITED12/02/200324/02/2003DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    K.A. STRIPP LIMITED20/02/200320/02/2003AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    COHESION DESIGN SERVICES LIMITED07/01/200320/02/2003AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MANUFACTURING (ESSEX) LIMITED20/02/200320/02/2003DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    UBW CONSULTANTS LIMITED20/02/200320/02/2003DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0