• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Dorothy May GRAEME - Página 205

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeDorothy
    Segundo NomeMay
    Último NomeGRAEME
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo0
    Renunciado9882
    Total9882

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    NORTHERN STRUCTURAL SERVICES LIMITED13/07/199813/07/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    LANCASTERS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED13/07/199813/07/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    DMQA (HOLDINGS) LIMITED13/07/199813/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CATESBY PROPERTIES LIMITED13/07/199813/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    A. BELL ELECTRICAL LIMITED13/07/199813/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MRC SYSTEMS LIMITED25/06/199813/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    PREMIUM ROOFING LIMITED10/07/199810/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    OAKVALE CONTRACTORS LIMITED22/05/199808/07/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    AB4 LTD08/07/199808/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    JB HATHERLEY BUILDERS & DECORATORS LTD.06/07/199806/07/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ABBEY ROOFING CONTRACTORS LIMITED06/07/199806/07/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BREDHURST PROPERTIES LIMITED02/07/199802/07/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    B. & M. HARLAND LIMITED01/07/199801/07/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    VSF RESIN & VARNISH LIMITED01/07/199801/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    PASSENGER DIRECT LIMITED01/07/199801/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    LINKTEC SOLUTIONS LIMITED16/06/199801/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    FRAMEWORK DESIGNS LIMITED24/04/199801/07/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    GLOBAL INSTRUMENTATION LIMITED29/06/199829/06/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BEE WILD LTD29/06/199829/06/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    DARTHUIZER UK LIMITED29/06/199829/06/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    R. D. BULL & SONS LIMITED25/06/199825/06/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    VR SANI-CO LTD25/06/199825/06/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    I T MEDIA (NORWICH) LIMITED25/06/199825/06/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BRADFORD BATHROOM COMPANY LIMITED24/06/199824/06/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    STONE'S TAXIS LIMITED24/06/199824/06/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ILLUMINA DIGITAL LIMITED24/06/199824/06/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ACCLAIM SOFTWARE LIMITED22/06/199822/06/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    TREE OF LIFE UK LIMITED02/04/199819/06/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    JOE PUBLIC RELATIONS LIMITED20/04/199818/06/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    INDUSTRIAL LUBRICANTS (UK) LIMITED16/06/199816/06/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ROHDEN UK LIMITED16/06/199816/06/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    M.I.T. PUBLISHING LIMITED16/06/199816/06/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    WHEATLAND SERVICES LIMITED22/04/199815/06/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    UNIT PUBS LIMITED11/06/199811/06/1998AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    INSIDEOUT MANAGEMENT DEVELOPMENT CONSULTANCY LIMITED11/06/199811/06/1998DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0