• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Dorothy May GRAEME - Página 276

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeDorothy
    Segundo NomeMay
    Último NomeGRAEME
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo0
    Renunciado9882
    Total9882

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    BRIK - TEC SERVICES LIMITED04/08/199204/08/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    UNI-LINK LOGISTICS LIMITED29/07/199229/07/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    FAIRPLANT LIMITED03/07/199229/07/1992LiquidaçãoSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HIGH QUALITY LIFESTYLES LIMITED27/07/199227/07/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CHAPSTONE LIMITED23/07/199223/07/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    REGALLOOK LIMITED20/05/199221/07/1992LiquidaçãoSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ESLINGTON TECHNICAL CONSULTANCY LIMITED17/07/199217/07/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    RIVERGREEN DEVELOPMENTS PLC14/07/199216/07/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    METRO REPRO LIMITED15/06/199216/07/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CLOVERMAY LIMITED10/04/199216/07/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CROMWELL TRUCK SALES LIMITED24/06/199215/07/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CROMWELL TRUCK RENTAL LIMITED23/06/199215/07/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SAUNDERS & FRENCH PRODUCTIONS LIMITED13/07/199213/07/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    L & L LIMITED10/07/199210/07/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    LINDEN CORNWALL LIMITED20/05/199206/07/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CHARTQUEST LIMITED10/04/199206/07/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    KINGSLAND CONSTRUCTION LIMITED10/01/199201/07/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    L.K.C. CONTRACTS LIMITED01/07/199201/07/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BADGERS FOODS LIMITED23/06/199223/06/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    NOBLEOAK LIMITED12/06/199222/06/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    KERAMIKOS LIMITED19/06/199219/06/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    C.A.S. MARKETING COMMUNICATIONS LIMITED20/03/199218/06/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    A.D.R. ENGINEERING LIMITED14/04/199212/06/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ASTONRANGE LIMITED16/03/199212/06/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    INITIATIVES (ARCHITECTS) LIMITED12/06/199212/06/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    GOODALLS OF LIVERPOOL LIMITED12/06/199212/06/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BRUNO FABRICS LIMITED02/06/199202/06/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    STAGE HOME DEVELOPMENTS LIMITED02/06/199202/06/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SILKCROSS DEVELOPMENTS LIMITED01/06/199201/06/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CINI-LITTLE (G.B.) LIMITED19/12/199129/05/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HAYGROVE INVESTMENTS LIMITED14/11/199127/05/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    GRAVITAS PROJECT CONSULTANTS LIMITED21/05/199221/05/1992DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    WATERSIDE LEISURE UK LIMITED20/05/199220/05/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BURACTIMM LIMITED19/05/199219/05/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    C L MANAGEMENT SERVICES LIMITED19/05/199219/05/1992AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0