• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Dorothy May GRAEME - Página 265

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeDorothy
    Segundo NomeMay
    Último NomeGRAEME
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo0
    Renunciado9882
    Total9882

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    PC RESTAURANTS LIMITED08/11/199318/01/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BRIAN HILL ESTATES LIMITED17/12/199318/01/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    NEW BARN FIELD CENTRE LIMITED06/12/199317/01/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ADSPACE 2000 LIMITED08/10/199314/01/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CRYSTALSPIRIT LIMITED24/12/199314/01/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    QUICK FIX LIMITED12/01/199412/01/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    B I JOHNSON CONTRACTORS LIMITED12/01/199412/01/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SAVILL FABRICATIONS LIMITED22/12/199312/01/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    DEERHOLME LIMITED16/11/199312/01/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BIO-PRODUCTIONS LIMITED11/01/199411/01/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    JOHN AYNSLEY (ARCHITECTURAL METALWORK) LIMITED10/01/199411/01/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BIMI LTD.09/11/199311/01/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SEYMAC AUTOMATON LIMITED10/01/199411/01/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    GLENORIE LIMITED12/11/199307/01/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    EUROMARINE INSURANCE SERVICES LIMITED08/11/199307/01/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    WILJON (SHEFFIELD) LIMITED06/01/199406/01/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    COOK FOOD LIMITED05/01/199405/01/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MAGMAKER LIMITED05/01/199405/01/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    PIEDRO (U.K.) LIMITED05/01/199405/01/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    DIAMONDSTAR LIMITED17/12/199305/01/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MARBLE & GRANITE FABRICATION LIMITED04/01/199404/01/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MONITOR MARKETING LIMITED24/12/199324/12/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    JUBILEE SHEET METAL WORKS LIMITED24/12/199224/12/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CLYNE INNS LIMITED22/12/199322/12/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    VECTIS ALLERGY LIMITED22/12/199322/12/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    AUSTELLGRANGE LIMITED17/11/199320/12/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CROSSLEY MANAGEMENT LIMITED20/08/199320/12/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MOUNTGRACE LIMITED08/12/199320/12/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    OMNICORP LIMITED17/12/199317/12/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HOLWAY LIMITED07/09/199315/12/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MILINC SOLUTIONS LIMITED14/12/199314/12/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HARBURY LIMITED08/11/199314/12/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HOLMSTALL LIMITED06/12/199310/12/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SMALLHEATH LIMITED01/12/199310/12/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ELDACOM LIMITED24/11/199309/12/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0