• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Dorothy May GRAEME - Página 232

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeDorothy
    Segundo NomeMay
    Último NomeGRAEME
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo0
    Renunciado9882
    Total9882

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    LARCHGLADE LIMITED20/09/199628/10/1996DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    C.J.W. HOTELS LIMITED25/10/199625/10/1996AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    R & C COMPONENTS LIMITED25/10/199625/10/1996AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    STANPRINT INVESTMENTS LIMITED16/10/199625/10/1996AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    AXIS MEDICAL LIMITED25/10/199625/10/1996DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    TELEVISION JUNCTION LIMITED25/10/199625/10/1996DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    UK VENEER SYSTEMS LIMITED24/10/199624/10/1996AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CHURCH GRESLEY (OLD HALL) BAR SERVICES LIMITED24/10/199624/10/1996AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    17/19 COURTFIELD ROAD FREEHOLD LIMITED24/10/199624/10/1996AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    COALVILLE COMMERCIAL SERVICES LIMITED24/10/199624/10/1996AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    COMPUTER FORENSIC INVESTIGATIONS LTD24/10/199624/10/1996DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    DIRECT-TO-PLATE LIMITED09/10/199623/10/1996AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    VEERE GRENNEY ASSOCIATES LIMITED24/09/199623/10/1996AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    JOHN LESTER PARTNERSHIP LIMITED22/10/199622/10/1996AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    KEYWAY LOCK SERVICES LIMITED22/10/199622/10/1996AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SUPERIOR (GRAIN AND MILLING EQUIPMENT) LIMITED22/10/199622/10/1996DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    RMS AUTOMATION SERVICES LIMITED18/10/199618/10/1996AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    R. I. DERRY & SON LIMITED18/10/199618/10/1996AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    THE DOOR AND WINDOW COMPANY LIMITED18/10/199618/10/1996DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    GALLAGHER KNOWD ASSOCIATES LIMITED18/10/199618/10/1996DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SUPPORTCARE LIMITED18/10/199618/10/1996DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    RUSSIAN CONNECTION TRANSLATORS & INTERPRETERS LIMITED18/10/199618/10/1996DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    S.T.N. P.A. & LIGHTING LTD17/10/199617/10/1996AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    STONAR DEVELOPMENTS LIMITED17/10/199617/10/1996AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    STEP FORWARD PUBLISHING LIMITED20/08/199617/10/1996AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HANSARD SECURITY LIMITED16/10/199616/10/1996DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MINERVA INFORMATION SYSTEMS LIMITED16/10/199616/10/1996DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    23 DEGREES LIMITED16/10/199616/10/1996DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    QUALITYLET UK LIMITED04/09/199616/10/1996LiquidaçãoSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SOLID BOND CONTROLS LIMITED15/10/199615/10/1996AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    TEXTILE CREATIONS LIMITED15/10/199615/10/1996DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    LEAFYGLADE LIMITED02/10/199615/10/1996DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    LINDSAY MARKETING ASSOCIATES LIMITED08/07/199614/10/1996DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    NATURAL GREEN CREATIVE SPACES LTD11/10/199611/10/1996AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    STU-ART LIMITED11/10/199611/10/1996DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0