• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Dorothy May GRAEME - Página 9

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeDorothy
    Segundo NomeMay
    Último NomeGRAEME
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo0
    Renunciado9882
    Total9882

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    CONNEXXION INTERNATIONAL LIMITED10/11/200410/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MACH (UK) LIMITED10/11/200410/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SHORELINE LEISUREWEAR LIMITED10/11/200410/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    STEAM REPLICAS LIMITED10/11/200410/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    WOODRUFF FIVE LIMITED10/11/200410/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    QUESTVALLEY ESTATES LIMITED27/10/200410/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    GM COOLING SERVICES LIMITED09/11/200409/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    PARKFIELD PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED09/11/200409/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HOOHAA LIMITED09/11/200409/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SHELHOMES LIMITED09/11/200409/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    QUAYLINK LIMITED29/10/200409/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    VICEROY HOMES LIMITED26/08/200409/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    APL CUBIC LIMITED28/06/200409/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MUCKY PUPS (G.X.) LIMITED08/11/200408/11/2004AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ARC TAUNTON LIMITED08/11/200408/11/2004AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    GIALLO CARS LIMITED17/06/200408/11/2004AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    PARKVIEW VEHICLE SOLUTIONS LIMITED11/06/200408/11/2004AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BURLEY'S MIDLANDS LIMITED08/11/200408/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SCOTT'S DISCOUNT APPLIANCES LIMITED08/11/200408/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    DEFTECH LIMITED08/11/200408/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    GENTRONICS LIMITED08/11/200408/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HODGSON CATERERS LIMITED08/11/200408/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    GENMART LIMITED08/11/200408/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    FIRTREE MARKETING LIMITED08/06/200405/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MORRISTON CONSTRUCTION LTD.03/11/200403/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    STOCK 2 U LIMITED03/11/200403/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    TAURUS ELECTRICAL LIMITED03/11/200403/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    T T S D LIMITED02/11/200402/11/2004AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    PSG SYSTEMS LIMITED02/11/200402/11/2004AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    C.L. FABRICATIONS LIMITED02/11/200402/11/2004AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BEAUMONT CORNISH SECURITIES LIMITED02/11/200402/11/2004AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HOLLYRIDGE SERVICES LIMITED07/06/200402/11/2004AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ALLSEALS ENGINEERING PRODUCTS LIMITED02/11/200402/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BROMPTON DISTRIBUTORS LIMITED02/11/200402/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CELIA CLYNE CATERING LIMITED01/06/200402/11/2004DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0