• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Dorothy May GRAEME - Página 266

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeDorothy
    Segundo NomeMay
    Último NomeGRAEME
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo0
    Renunciado9882
    Total9882

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    HISTORICALLY YOURS LIMITED07/12/199307/12/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    S.G.C. SCAFFOLDING LIMITED06/12/199306/12/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    D R M ASSOCIATES LIMITED06/12/199306/12/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    GREEN TIMBER LIMITED02/12/199302/12/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    DELTA PIPELINES LIMITED02/12/199302/12/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BURRELLS WHARF FREEHOLDS LIMITED29/10/199301/12/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CITY COMPUTERS (SOUTHAMPTON) LIMITED30/11/199330/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    RICHARDSON DEVELOPMENTS LIMITED22/11/199329/11/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ROPE WALK PROPERTIES LIMITED19/11/199329/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    TROPICALBOND LIMITED28/08/199329/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    YORK CONSTRUCTION LIMITED25/11/199325/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    E.T. HEATING LIMITED25/11/199325/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ALCOMBE HOUSE LIMITED22/11/199322/11/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CACHE BENEFIT LIMITED19/11/199319/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HAYLETON LIMITED13/09/199319/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    U.K. SOFTWARE LIMITED24/09/199317/11/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MANAGED TRAINING SERVICES LIMITED16/11/199316/11/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    WESTGROVE SERVICES LIMITED15/11/199315/11/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    S.T.B. FENCING LIMITED05/11/199310/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ANGLEBROOK LIMITED03/11/199310/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    KINGSWOOD JOINERY AND BUILDING LIMITED09/11/199309/11/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    C A LEE DESIGNS LIMITED08/11/199308/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    THE PARISH MEWS RESIDENTS COMPANY LIMITED05/11/199305/11/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    XANADU (HULL) LIMITED05/11/199305/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ALAN STUART ENGINEERING LIMITED03/11/199303/11/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    METCALFE ELECTRICAL (YORKSHIRE) LIMITED03/11/199303/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    QUICKDUCT LIMITED26/10/199302/11/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    GLANDOVER LIMITED07/10/199301/11/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ROSS BROTHERS CONSTRUCTION LIMITED15/10/199301/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SINGAPORA LIMITED26/08/199329/10/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    VENTURE INTERIORS LIMITED29/10/199329/10/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MAPLECROFT LIMITED29/09/199328/10/1993DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    PYRANS LIMITED23/09/199328/10/1993LiquidaçãoSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    AZETS TAIT WALKER MANAGEMENT LIMITED26/10/199326/10/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    UNIFOREST LIMITED12/07/199318/10/1993AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0