• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Dorothy May GRAEME - Página 257

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeDorothy
    Segundo NomeMay
    Último NomeGRAEME
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo0
    Renunciado9882
    Total9882

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    QUINTILIAN TRAINING LIMITED06/10/199426/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HARLANDS GROUP LTD25/10/199425/10/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HARLANDS SERVICES LTD25/10/199425/10/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    FOREMOST U.K. LIMITED24/10/199424/10/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    MARGATE LANGUAGE CENTRE LIMITED24/10/199424/10/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    NHR LIMITED06/10/199424/10/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ARMATURE WILSON LIMITED06/10/199421/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BALLYREGAN LIMITED06/10/199421/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SLEEP TECHNOLOGY LIMITED14/10/199420/10/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    DIOMED ENGINEERING DESIGNS LIMITED20/10/199420/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    DELTA S4 SYSTEMS LIMITED18/10/199418/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    TRUST ME TRAVEL LIMITED18/10/199418/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    TRADE WINDOWS AND SUPPLIES LIMITED06/10/199417/10/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    KRYPTONTECH LIMITED06/10/199417/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SIMON LING & CO. LIMITED14/10/199414/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    THE BODY SHOP (M/C) LIMITED14/10/199414/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    THE EASTCHESTER GROUP LIMITED06/10/199414/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    EASTCHESTER UNDERWRITING LIMITED06/10/199414/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    FAIN REDFERN LIMITED06/10/199413/10/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    JPS FIRE & SECURITY LIMITED12/10/199412/10/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    INDEPENDENT IMPORTERS (UK) LIMITED12/10/199412/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BRUNTONS FINANCE LIMITED11/10/199411/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    RJL DESIGNS LTD11/10/199411/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CREATIVE FIRES U.K. LIMITED11/10/199411/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    I.D.D.P. LIMITED10/10/199410/10/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CASTLE MOTORS LIMITED06/10/199410/10/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    KIRBY DESIGNS LIMITED10/10/199410/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    IMPROVEDSYSTEMS LIMITED06/10/199407/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    N J SMART & CO. LIMITED06/10/199406/10/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ACS LINING LIMITED08/08/199406/10/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    THREE GREENS LIMITED03/08/199406/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ADDISON ROAD MAISONETTES LIMITED04/10/199404/10/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    TECHNOPOLY LIMITED04/10/199404/10/1994AtivaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    U.K. FASTRACK LIMITED30/09/199430/09/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    KINGLINK LIMITED30/09/199430/09/1994DissolvidaSecretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0