• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Howard THOMAS - Página 118

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeHoward
    Último NomeTHOMAS
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo7
    Renunciado7852
    Total7859

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    WIMBORNE PROACTIVE MARKETING LTD25/04/200114/05/2001DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PEERSTART LIMITED25/04/200107/06/2001DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BRIDGEGATE PRINTING COMPANY LIMITED25/04/200125/04/2001DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PINEWOOD PRINT SERVICES LIMITED25/04/200125/04/2001DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MISYS EAGLEYE LIMITED25/04/200125/04/2001DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    APOLLO MARKETING (EUROPE) LIMITED25/04/200125/04/2001DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    YELL LIMITED25/04/200124/05/2001AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    QUEEN STREET LIMITED23/04/200123/04/2001DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    AESTHETICS INTERNATIONAL LIMITED23/04/200123/04/2001DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    NSS LIMITED20/04/200120/04/2001AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    AFRI LONDON LIMITED20/04/200120/04/2001DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ENBEE ENTERPRISES LIMITED20/04/200120/04/2001AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BLACKBOX TECHNOLOGIES LIMITED20/04/200120/04/2001AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    JARG LIMITED20/04/200120/04/2001AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    THE BULLNOSE MORRIS CLUB LIMITED20/04/200120/04/2001AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    F BAR LIMITED19/04/200119/04/2001DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BESPOKE POWER SYSTEMS LIMITED19/04/200119/04/2001AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    D J SEGRUE LIMITED18/04/200118/04/2001DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    THE HORIZON BISCUIT COMPANY LIMITED18/04/200124/08/2001DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DAVID LEE EDI SERVICES LIMITED18/04/200118/04/2001AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LCBL LIMITED17/04/200117/04/2001DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    RECTORY BARNS LIMITED17/04/200117/04/2001AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PORTMAN MEDIA ASSETS (NO. 2) LIMITED17/04/200117/04/2001LiquidaçãoSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    FREE ISSUE MACHINING LIMITED12/04/200112/04/2001AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    GLOBAL DOTCOM SOLUTIONS LIMITED12/04/200112/04/2001DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    COBALT INFORMATION DESIGN LIMITED11/04/200111/04/2001AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    FILMACCOUNTING LIMITED10/04/200110/04/2001DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    VIAGLOBE LIMITED09/04/200105/06/2001DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MCCOLLS OF ARGYLL LIMITED06/04/200106/04/2001DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LIFESTYLE APPLIANCES LIMITED06/04/200106/04/2001AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    YH LIMITED04/04/200124/05/2001AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    VIGORAT LIMITED04/04/200110/12/2001DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    STARSIGN BUILDING MAINTENANCE LIMITED04/04/200104/04/2001DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    HIGH HOLBORN HOUSE NO. 1 LIMITED03/04/200114/06/2001DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    21 RICHBORNE TERRACE RESIDENTS COMPANY LIMITED03/04/200123/04/2002AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0