• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Howard THOMAS - Página 163

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeHoward
    Último NomeTHOMAS
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo7
    Renunciado7852
    Total7859

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    MERALI'S LIMITED25/03/199825/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MEDGAL CARE LIMITED25/03/199825/03/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CARDSUIT LIMITED16/03/199824/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LOVEITTS FINANCIAL PLANNING LIMITED24/03/199824/03/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LASERSLIDE LIMITED18/03/199824/03/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CENTRAL PROPERTY ESTATES LIMITED23/03/199823/03/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LA MANCHA LIMITED20/03/199820/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PLANTCARE FOLIAGE DISPLAY SPECIALISTS LIMITED20/03/199820/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BAROTE (LONDON) LIMITED20/03/199820/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SKEGNESS SPECSAVERS LIMITED20/02/199820/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SKEGNESS VISIONPLUS LIMITED20/02/199820/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    KIRKCALDY SPECSAVERS LIMITED18/02/199820/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    EQUINOX TRAINING SOLUTIONS LIMITED18/03/199818/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    NORCOURT RESIDENTS COMPANY LIMITED18/03/199818/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LOUDSPACE LIMITED18/03/199818/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ALDER COMPUTER PROJECT MANAGEMENT LIMITED18/03/199818/03/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    TEAM THAMES VALLEY LIMITED18/03/199818/03/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    VOICECOM GROUP LIMITED18/03/199818/03/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    TIGGES LIMITED16/03/199816/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BLUE TOWN LIMITED16/03/199816/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WOLVERLEY HOMES LIMITED16/03/199816/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    FAIRCLOUGHS OF BOLTON LIMITED13/03/199813/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    RIBBONS CLOTHING LIMITED12/03/199812/03/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    THE KLINE COPY CENTRE LIMITED12/03/199812/03/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SANCTON WOOD SCHOOL LIMITED11/03/199811/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    4 AVENUE ELMERS (RESIDENTS ASSOCIATION) LIMITED11/03/199811/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    RODBER LTD11/03/199811/03/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    HALSBURY ESTATES LIMITED10/03/199810/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SM FARMS LIMITED10/03/199810/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DELTA PARTNERSHIP P.D.R. LIMITED06/03/199806/03/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WEETSLADE FARMS LIMITED06/03/199806/03/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    VOICECOM LIMITED04/03/199804/03/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WHITEBIRK DEVELOPMENTS LIMITED03/03/199803/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MOBILE HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED02/03/199802/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BLUE HAZE MANAGEMENT CO. LIMITED02/03/199802/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0