• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Howard THOMAS - Página 162

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeHoward
    Último NomeTHOMAS
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo7
    Renunciado7852
    Total7859

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    AGS ENTERPRISES LIMITED23/04/199823/04/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CARSPECT (UK) LIMITED22/04/199822/04/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    20 BURNBURY ROAD LIMITED21/04/199821/04/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    FORDBRIDGE ENGINEERING LIMITED21/04/199821/04/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DARK LIGHT DEVELOPMENTS LIMITED21/04/199821/04/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BROWN RUDNICK LIMITED21/04/199821/04/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    2 GUILFORD STREET LIMITED15/04/199831/03/1999AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    RAYNERS BAKERY LIMITED15/04/199815/04/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    260 FERME PARK ROAD (RESIDENTS ASSOCIATION) LIMITED14/04/199814/04/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    AIMTOAID LIMITED14/04/199801/05/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DIRECT DISCOUNT STORES LIMITED14/04/199814/04/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WELLINGBOROUGH VISIONPLUS LIMITED14/04/199807/05/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    VERMIN X ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED08/04/199808/04/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    METAMORPHOSIS MANAGEMENT LIMITED07/04/199807/04/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SA RETURNS LIMITED07/04/199809/04/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PORTSMOUTH VISIONPLUS LIMITED07/04/199807/05/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    METAMORPHOSIS PRODUCTIONS LIMITED07/04/199813/05/1998LiquidaçãoSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    FLASHGUARD LIMITED07/04/199830/04/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SPIRIT DESIGN CONSULTANTS LIMITED07/04/199807/04/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    TELLING POINT LIMITED06/04/199806/04/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WOODSIDE CARS LIMITED03/04/199803/04/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ST. JOHN DEVELOPMENTS LIMITED02/04/199802/04/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    FLYING BRANDS LIMITED01/04/199801/04/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PRINTPLAY LIMITED31/03/199802/04/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    G.T. WINDOWS LIMITED30/03/199830/03/1998LiquidaçãoSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    AAI/ACL TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED30/03/199830/03/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MERALI'S (IOM) LIMITED25/03/199825/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MERALI'S LIMITED25/03/199825/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MEDGAL CARE LIMITED25/03/199825/03/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LOVEITTS FINANCIAL PLANNING LIMITED24/03/199824/03/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CENTRAL PROPERTY ESTATES LIMITED23/03/199823/03/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LA MANCHA LIMITED20/03/199820/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PLANTCARE FOLIAGE DISPLAY SPECIALISTS LIMITED20/03/199820/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MOBILECALL LIMITED20/03/199820/04/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BAROTE (LONDON) LIMITED20/03/199820/03/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0