• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Howard THOMAS - Página 176

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeHoward
    Último NomeTHOMAS
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo7
    Renunciado7852
    Total7859

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    OCKENDON PETROLEUM SERVICES LIMITED23/01/199723/01/1997DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    FORCERECALL LIMITED26/11/199620/01/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LEWIS FACILITIES LIMITED15/01/199715/01/1997DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    FRANK ARNOLD LIMITED15/01/199715/01/1997DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PRODAIR SERVICES LIMITED10/09/199615/01/1997DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    9 ALFRED ROAD MANAGEMENT COMPANY LIMITED14/01/199714/01/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    N.R.C. PLANT LIMITED13/01/199713/01/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SHRUBGLADE LIMITED26/11/199609/01/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CAVOK LIMITED27/11/199607/01/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CANDMINSTER LIMITED27/11/199602/01/1997DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PLASTICON AUTOMATED EQUIPMENT LIMITED31/12/199631/12/1996DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LOUDOUN HOUSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED30/12/199630/12/1996AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ADAS INTERNATIONAL LIMITED27/12/199627/12/1996DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    AD2 REALISATIONS LIMITED27/12/199627/12/1996DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ADAS RESEARCH & DEVELOPMENT LIMITED27/12/199627/12/1996DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    R.O.B. PROPERTIES LIMITED23/12/199623/12/1996AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ICON INTERNATIONAL SERVICES LIMITED20/12/199620/12/1996AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    OAKLEY PROPERTY (SUSSEX) LIMITED20/12/199620/12/1996AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    GLOBECOM LTD20/12/199620/12/1996DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    THE VITALE GROUP LIMITED19/12/199619/12/1996AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WALTON ST. DESIGN WORKS LIMITED18/12/199618/12/1996AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    GINGER SOFT LIMITED16/12/199616/12/1996AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    52 RUSSELL ROAD RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED16/12/199616/12/1996AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    COATES QUAY RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED13/12/199613/12/1996AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    EAGLE ENTERPRISES LTD12/12/199612/12/1996AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    NUF CONSULTANCY LIMITED12/12/199612/12/1996AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    KENTON SHOPPING CENTRE LIMITED12/12/199612/12/1996DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    HARMONY EDUCATION CONSULTANTS LIMITED12/12/199612/12/1996DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WICKEYPOINT LIMITED25/10/199612/12/1996DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    X-NET (SERVICES) LTD11/12/199611/12/1996AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    GTI SOFTWARE LIMITED10/12/199610/12/1996AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BRAEHEAD PROPERTY INVESTMENTS LIMITED03/12/199610/12/1996AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    RICKARDS MEDIA SERVICES LIMITED11/11/199610/12/1996AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SURBITON SERVICES LIMITED09/12/199609/12/1996DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SAMOVAR LIMITED09/12/199609/12/1996DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0