• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Howard THOMAS - Página 196

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeHoward
    Último NomeTHOMAS
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo7
    Renunciado7852
    Total7859

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    WOODROUGH RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED22/12/199422/12/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MISCELLANEA HOTELS AND LEISURE LIMITED22/12/199422/12/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SEAQUIST CLOSURES LIMITED21/12/199421/12/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BOWES HOTELS LIMITED20/12/199420/12/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PAT LEWIS & SON LIMITED20/12/199420/12/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DELPHI ASSETS LIMITED20/12/199420/12/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ITEM WALES LTD.20/12/199420/12/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SAPORI D' ITALIA UK LIMITED20/12/199420/12/1994LiquidaçãoSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    XWV LIMITED19/12/199419/12/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    GAS CENTRE LIMITED19/12/199419/12/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    HELMAC PRODUCTS LIMITED19/12/199430/01/1995DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    GRANDOMAN LIMITED19/12/199422/12/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MINEHOME LIMITED19/12/199419/12/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    EPS SOFTWARE LIMITED16/12/199416/12/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    EDINBURGH VISIONPLUS LIMITED09/12/199401/01/1995AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SECURITY DOG UNITS UK LIMITED09/12/199409/12/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    METAL REDUCTION PROCESSING LIMITED08/12/199408/12/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    EURO REP LIMITED05/12/199405/12/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    EVOLUTION CLOTHING CO LIMITED01/12/199401/12/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    THE FRIARY HOTEL LIMITED01/12/199401/12/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    G.K. BEN & ASSOCIATES LIMITED29/11/199429/11/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    YOUNG TECHNICAL SERVICES LIMITED29/11/199429/11/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WOLVERSTON ESTATES LIMITED28/11/199428/11/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CARBROSAH LTD28/11/199428/11/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    R & S PLANT HIRE LIMITED25/11/199425/11/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    P R ENGINEERING LIMITED25/11/199425/11/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CIFE LIMITED22/11/199422/11/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PRESTON VISIONPLUS LIMITED22/11/199422/11/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PENTOAK LIMITED16/11/199416/11/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    FRIENDS OF EXMOOR PONIES LIMITED16/11/199419/12/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    TUNBRIDGE WELLS VISIONPLUS LIMITED09/11/199409/11/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DMX SERVICES LIMITED09/11/199409/11/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    TUNBRIDGE WELLS SPECSAVERS LIMITED09/11/199409/11/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ROUNDWAY COURT MANAGEMENT COMPANY LIMITED07/11/199407/11/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    COVENT GARDEN HOTEL LIMITED07/11/199409/12/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0