• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Howard THOMAS - Página 205

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeHoward
    Último NomeTHOMAS
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo7
    Renunciado7852
    Total7859

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    FREETIME COMMUNICATIONS LIMITED22/12/199322/12/1993DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SPINDLEBERRY INNS LIMITED17/12/199317/12/1993DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SUMMERHOUSE MUSIC LIMITED16/12/199316/12/1993AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    STONEGUARD (HOLDINGS) PLC14/12/199314/12/1993DissolvidaDiretor nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    STONEGUARD (HOLDINGS) PLC14/12/199314/12/1993DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    COMPUTER SERVICES LIMITED13/12/199313/10/1993DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SYNTEGON TELSTAR UK LTD08/12/199308/12/1993AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ELEVEN UPPER PARK ROAD LIMITED08/12/199308/12/1993AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    TEMPERON LIMITED08/12/199323/12/1993AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    EUROPEAN CONSULTING SERVICES LTD08/12/199314/12/1993DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    JOHN NEVILLE & CO LIMITED07/12/199307/12/1993DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    IPSWICH VISIONPLUS LIMITED03/12/199305/05/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ROCKFIELD RECORDS LIMITED01/12/199301/12/1993DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    IDLE VISIONPLUS LIMITED01/12/199301/12/1993AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    R.W. FLETCHER & SON LIMITED30/11/199330/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    REDDITCH VISIONPLUS LIMITED30/11/199301/12/1993AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    35 DARTMOUTH PARK AVENUE MANAGEMENT COMPANY LIMITED29/11/199329/11/1993AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CHANGELINK LIMITED29/11/199329/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    COX & KINGS TOURS LIMITED29/11/199329/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    COX & KINGS HOLDINGS LIMITED29/11/199329/11/1993AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    EBBW VALE VISIONPLUS LIMITED26/11/199326/11/1993AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ORBIT NEW HOMES LIMITED26/11/199326/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SUTTON COLDFIELD VISIONPLUS LIMITED24/11/199324/11/1993AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    STONEGUARD (MIDLANDS) LIMITED23/11/199323/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BROOKDALE INDUSTRIAL FASTENERS LIMITED23/11/199323/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ANETHOS LTD.22/11/199322/11/1993AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    02873742 LIMITED19/11/199316/12/1993LiquidaçãoSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MICROCHEM SYSTEMS LIMITED19/11/199319/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PLONTANE LIMITED17/11/199309/12/1993DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PEDMORE COMPUTER SERVICES LIMITED16/11/199316/11/1993AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    M & N (MANAGEMENT SERVICES) LTD15/11/199315/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    L.C. MITSIOU & SON LIMITED11/11/199311/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    RHYTHMIC MEDIA LIMITED10/11/199310/11/1993DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    FAWLEY MEWS RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED09/11/199309/11/1993AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    NORTH HYDE ROAD RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED09/11/199309/11/1993AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0