• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Howard THOMAS - Página 202

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeHoward
    Último NomeTHOMAS
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo7
    Renunciado7852
    Total7859

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    WHITTLE INDUSTRY DATA LIMITED10/05/199410/05/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    RUSSELL MARKS (FINANCIAL SERVICES) LIMITED09/05/199409/05/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    NORMANHURST LIMITED09/05/199409/05/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    THE EDUCATION WAREHOUSE LIMITED06/05/199406/05/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WEBSTER'S FINE ART SERVICES LIMITED06/05/199406/05/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ACCESS INTERIORS LIMITED04/05/199404/05/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    M. POWER TOOLS LIMITED03/05/199403/05/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ROSEWOOD MANAGEMENT SERVICES LIMITED29/04/199429/04/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SUTTON SPECSAVERS LIMITED26/04/199426/04/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MISTRAL INTERNET LIMITED19/04/199419/04/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    REALITY GRAPHICS LIMITED19/04/199419/04/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MACCOM TRAINING & CONSULTANCY LIMITED18/04/199408/04/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    HI-TECH AUDIO LIMITED12/04/199412/04/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SOLUMETRICS LIMITED12/04/199412/04/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ALDOW CONSTRUCTION LIMITED11/04/199411/04/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    IFIELD ROAD LIMITED11/04/199427/06/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DENMARK VILLAS LIMITED07/04/199407/04/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    THINK CORPORATE REPORTING LIMITED07/04/199407/04/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WILTON LODGE RESIDENTS ASSOCIATION (1994) LIMITED07/04/199407/04/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MICHAEL HALL ROOFING LIMITED06/04/199406/04/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SKELMERSDALE VISIONPLUS LIMITED05/04/199405/04/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SKELMERSDALE SPECSAVERS LIMITED05/04/199405/04/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    JENOR (TRAVEL) LIMITED29/03/199429/03/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    THE BRIARS EVESHAM (RESIDENTS) MANAGEMENT LIMITED25/03/199425/03/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    GLOBAL MARITIME SCOTLAND LIMITED25/03/199425/03/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    OBVIOUS LIMITED25/03/199410/04/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    OBUYOURS LIMITED24/03/199420/05/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    INDEPENDENT SURVEY SERVICES LIMITED24/03/199424/03/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    THE AMBASSADORS (HOVE) LIMITED23/03/199423/03/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CHANNEL X LIMITED21/03/199421/03/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    TAYLOR INDUSTRIAL CLUTCH SUPPLIES LIMITED18/03/199418/03/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    HIGH TECH TUBES LIMITED15/03/199415/03/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ASHLEY GARDENS RESOURCE CENTRE LIMITED14/03/199413/05/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WORKFLAIR LIMITED14/03/199417/03/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    TIMETEAM LIMITED14/03/199414/03/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0