• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Howard THOMAS - Página 155

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeHoward
    Último NomeTHOMAS
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo7
    Renunciado7852
    Total7859

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    PORTMELLON APARTMENTS LIMITED02/11/199802/11/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    11 POWIS GROVE MANAGEMENT COMPANY LIMITED02/11/199802/11/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DELI FRESH CHILLED FOODS LIMITED02/11/199825/11/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    K.J. WAKELING LIMITED02/11/199802/11/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CEE VEE LIMITED29/10/199829/10/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    GLOBAL EVENT SERVICES LIMITED28/10/199828/10/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    GODALMING CENTRAL LIMITED28/10/199828/10/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    V P TECH AND INVESTMENT LIMITED27/10/199827/10/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    S.M. LAMPE LIMITED27/10/199827/10/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MILTON HALL ESTATES LIMITED27/10/199827/10/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SOUTHERHAM SERVICES LIMITED27/10/199827/10/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BLACKBURN TRAILERS LIMITED27/10/199827/10/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BAILIFF STREET FLAT MANAGEMENT COMPANY LIMITED26/10/199826/10/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MILLENNIUM ADJUSTERS LIMITED26/10/199826/10/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    AUCTION UK (M/CR) LIMITED23/10/199823/10/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    03655200 LIMITED23/10/199823/10/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ROWLY EDGE RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED23/10/199823/10/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    COLEMANS OFFICE SUPPLIES LIMITED23/10/199823/10/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SMS HOWARDS LABELS LIMITED22/10/199822/10/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    Q-BIT CONSULTANTS LIMITED21/10/199821/10/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ALLTRACK CREME LIMITED21/10/199821/10/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MARCQ-JOCKEY (FOOD SUPPLIES) LIMITED20/10/199820/10/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LIFETIME FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED20/10/199820/10/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    JACKSONS COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED19/10/199819/10/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    HAMMERSMITH VISIONPLUS LIMITED19/10/199819/10/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    HAMMERSMITH SPECSAVERS LIMITED19/10/199819/10/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    NEWBURN CONSULTING LIMITED19/10/199819/10/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CABBELL PUBLICATIONS LIMITED19/10/199819/10/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    GLOBAL ENVELOPE MACHINERY LIMITED19/10/199819/10/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CORPORATE GROUP INTERNATIONAL LTD16/10/199816/10/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    EGYPTIAN LINEN COMPANY LIMITED14/10/199814/10/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PEPPERMINTS LIMITED12/10/199819/10/1998DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    11 BURLINGTON ROAD LIMITED12/10/199812/10/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    W.I. FLATS MANAGEMENT COMPANY LIMITED12/10/199812/10/1998AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    FREEDAY LIMITED08/10/199808/10/1998LiquidaçãoSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0