• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Howard THOMAS - Página 198

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeHoward
    Último NomeTHOMAS
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo7
    Renunciado7852
    Total7859

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    PETERMAN EUROPE LIMITED10/10/199410/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    EASTSIDE STORY LIMITED10/10/199410/10/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BOLTON VISIONPLUS LIMITED06/10/199406/10/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    T.O.L. DECORATORS LIMITED06/10/199406/10/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    THE EAGLESCLIFFE ENGINEERING COMPANY LIMITED06/10/199417/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    TEP 1988 MANAGEMENT COMPANY LIMITED06/10/199406/10/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BOLTON SPECSAVERS LIMITED06/10/199406/10/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LICHFIELD VISIONPLUS LIMITED06/10/199406/10/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DARTMOUTH CAPITAL ADVISORS LIMITED06/10/199422/11/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LICHFIELD SPECSAVERS LIMITED06/10/199406/10/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DRIVEON LIMITED06/10/199411/10/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ALPHA LABELS AND SIGNS LIMITED05/10/199405/10/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    STATION AVENUE (EWELL) MANAGEMENT COMPANY LIMITED04/10/199404/10/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CLOWES DEVELOPMENTS (SCOTLAND) LIMITED03/10/199403/10/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BLYTH VISIONPLUS LIMITED03/10/199403/10/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    COATBRIDGE SPECSAVERS LIMITED30/09/199430/09/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ANGLIA GAS CENTRE LIMITED30/09/199430/09/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DOVER VISIONPLUS LIMITED30/09/199430/09/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    COATBRIDGE VISIONPLUS LIMITED30/09/199430/09/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DOVER SPECSAVERS LIMITED30/09/199430/09/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BEXLEYHEATH VISIONPLUS LIMITED29/09/199429/09/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BARNET VISIONPLUS LIMITED29/09/199429/09/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BEXLEYHEATH SPECSAVERS LIMITED29/09/199429/09/1995AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SHEFFIELD VISIONPLUS LIMITED29/09/199429/09/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BARNET SPECSAVERS LIMITED29/09/199429/09/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    KILLIESER AVENUE MANSIONS LIMITED28/09/199428/09/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    THE WHITE HOUSE (ESHER) MANAGEMENT COMPANY LIMITED27/09/199427/09/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    QUAD VISION LIMITED22/09/199422/09/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    APPLIED GEOTECHNICAL ENGINEERING LIMITED20/09/199420/09/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    NINETEEN ST. LUKES AVENUE LIMITED20/09/199420/09/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    47-54 MANAGEMENT LIMITED19/09/199419/09/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    TRACE PUBLICATIONS LIMITED14/09/199430/09/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    NORTH WEST CONTAINERS LIMITED14/09/199414/09/1994AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    AMPPOINT (U.K.) LIMITED13/09/199413/09/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BRITISH LAND HERCULES NO.3 LIMITED13/09/199430/09/1994DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0