• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Howard THOMAS - Página 63

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeHoward
    Último NomeTHOMAS
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo7
    Renunciado7852
    Total7859

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    A. EDGLEY LIMITED31/12/200331/12/2003AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DNA PROPERTY PARTNERS LIMITED31/12/200331/12/2003AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PALACOM SYSTEMS LIMITED31/12/200331/12/2003DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    INVEST CROATIA LIMITED31/12/200331/12/2003DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LYNEHAM GARDENS MANAGEMENT COMPANY LIMITED24/12/200324/12/2003AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    OUR RIGHT TO READ24/12/200324/12/2003AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    TOTTERIDGE HOUSE RESIDENTS LIMITED22/12/200024/12/2003AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    HUNSTANTON TOWER MANAGEMENT LIMITED23/12/200323/12/2003AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WILSON SANDFORD (HOVE) LIMITED22/12/200322/12/2003AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DANEBANK TRAVEL LIMITED22/12/200322/12/2003DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    J & D NEWALL (BUILDERS) LTD22/12/200322/12/2003DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SPORTMIND LIMITED19/12/200319/12/2003AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    GENTLEMEN'S TONIC LIMITED19/12/200319/12/2003LiquidaçãoSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    OLYMPUS CONSOLIDATED (HOLDINGS (UK) LIMITED18/12/200318/12/2003DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    KLIK DEVELOPMENTS LIMITED18/12/200318/12/2003DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    VALIDUS INVEST LTD17/12/200317/12/2003DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MOUNTFIELD ESTATES LIMITED01/12/200317/12/2003DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LUTON TOWN FOOTBALL CLUB LIMITED26/11/200317/12/2003DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MINTMIST LIMITED16/12/200316/12/2003AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    KENWOOD GRANGE MANAGEMENT COMPANY LIMITED16/12/200316/12/2003AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WELLMERE LIMITED16/12/200316/12/2003DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    THE GRANGE (SOMERTON) MANAGEMENT COMPANY LIMITED12/12/200312/12/2003AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    FRANKLYNN DEVELOPMENTS (HAYWARDS HEATH) LIMITED12/12/200312/12/2003DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    UNITAS DEVELOPERS LIMITED12/12/200312/12/2003DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PUMPS AWAY LIMITED12/12/200312/12/2003DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SEVA PATIDAR LIMITED11/12/200311/12/2003AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DISCDAY LIMITED01/12/200311/12/2003AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CAMERON SCOTT OPTIONS LIMITED11/12/200311/12/2003DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    INDEPENDENT FILM & TELEVISION COLLEGE11/12/200311/12/2003DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MALCOLM LAMBERT LANDSCAPES LIMITED10/12/200310/12/2003AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WAINGATE (HUDDERSFIELD) LIMITED10/12/200310/12/2003AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CAMBRIDGE DIRECT TREE SEEDING LIMITED09/12/200309/12/2003AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DEECARE LIMITED09/12/200309/12/2003AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ST. JOHN'S WESTMINSTER RTM COMPANY LIMITED09/12/200309/12/2003AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WENHAM CARTER LTD09/12/200309/12/2003AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0