• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Howard THOMAS - Página 167

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeHoward
    Último NomeTHOMAS
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo7
    Renunciado7852
    Total7859

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    SITTINGBOURNE SPECSAVERS LIMITED04/11/199704/12/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    HARSEV CO INTERNATIONAL LIMITED03/11/199703/11/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    EMCO UK LIMITED31/10/199731/10/1997DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    KINGS MARINE LIMITED30/10/199730/10/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SILENT SOUND FILMS LIMITED27/10/199727/10/1997DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SPELSBERG ELS UK LTD24/10/199724/10/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BRANDYWELL LIMITED24/10/199724/10/1997DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    132 MINNIS ROAD RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED23/10/199723/10/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    GREAT FARM WILSTONE (MANAGEMENT) LIMITED23/10/199723/10/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    IRONRIDGE CRAFTS LIMITED23/10/199723/10/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LEGALMARK LIMITED22/10/199713/11/1997DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    RICH FILMS LIMITED21/10/199721/10/1997DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SORTCOMM LIMITED20/10/199729/10/1997DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ARMTECH LIMITED20/10/199720/10/1997DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LANGFELD DIELEX EUROPE LIMITED17/10/199717/10/1997DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WELLINGBOROUGH SPECSAVERS LIMITED16/10/199713/11/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    GOLF LINKS PUBLISHING LIMITED16/10/199716/10/1997DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DESSNA COMPANY LIMITED15/10/199715/10/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CYCLONE MOBILITY AND FITNESS LIMITED15/10/199715/10/1997DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ENABLING IT LIMITED14/10/199714/10/1997DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    EDGBASTON HEALTHCARE LIMITED14/10/199714/10/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    THE PONY OF THE YEAR SHOW LIMITED14/10/199729/10/1999AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    RENCO NETS LIMITED13/10/199713/10/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    J. CAVANAGH LIMITED13/10/199713/10/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LYNDON LEASING LIMITED10/10/199705/11/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    TOPBOOK LIMITED10/10/199717/10/1997DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    45 BLACKWATER ROAD (EASTBOURNE) RESIDENTS COMPANY LIMITED10/10/199710/10/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BIOREGIONAL MINIMILLS (UK) LIMITED09/10/199709/10/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    DOUBLECLICK EUROPE LIMITED08/10/199708/10/1997DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    HUSKARDS CARE LIMITED07/10/199707/10/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PADGETT'S ROAD HAULAGE LIMITED06/10/199706/10/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    AMBLEHUNT LIMITED03/10/199709/10/1997DissolvidaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PRIVATE ASSET MANAGEMENT LIMITED02/10/199702/10/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CHESTNUT GARDENS (SONNING) LIMITED02/10/199702/10/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    THE PET CREMATORIUM LIMITED01/10/199701/10/1997AtivaSecretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0