Dorothy May GRAEME - Page 124
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Dorothy |
Deuxième prénom | May |
Nom de famille | GRAEME |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 9882 |
Total | 9882 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G S JOINERY LIMITED | 21 févr. 2002 | 21 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MACARTHUR'S CONSTRUCTION LIMITED | 21 févr. 2002 | 21 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BEDINGFIELD LIFTING LIMITED | 28 janv. 2002 | 21 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MJT CRANE HIRE LIMITED | 20 févr. 2002 | 20 févr. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MGL (RUGBY) LIMITED | 20 févr. 2002 | 20 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
EUROPE DIRECT LIMITED | 29 nov. 2001 | 20 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
KEVIN JACKSON BUILDING CONSULTANTS LIMITED | 19 févr. 2002 | 19 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LANE RENTAL (PLANT HIRE) SERVICES LIMITED | 18 févr. 2002 | 18 févr. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
NATURES LABORATORY LIMITED | 18 févr. 2002 | 18 févr. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PAT COSHH SERVICES LIMITED | 18 févr. 2002 | 18 févr. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LRS PROPERTIES LIMITED | 18 févr. 2002 | 18 févr. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ABS HOLDINGS LIMITED | 18 févr. 2002 | 18 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
STARNES (UCKFIELD) LIMITED | 18 févr. 2002 | 18 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SECURITY CCTV LIMITED | 18 févr. 2002 | 18 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ARCHITECTURAL GLAZING SOLUTIONS LIMITED | 18 févr. 2002 | 18 févr. 2002 | Liquidation | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TANATOMY LIMITED | 15 févr. 2002 | 15 févr. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BARRY FLEMING AND PARTNERS (TAX, TRUSTS AND INVESTMENT PLANNING) LIMITED | 15 févr. 2002 | 15 févr. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HERNE ELECTRONICS LIMITED | 15 févr. 2002 | 15 févr. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DOMEK LIMITED | 15 févr. 2002 | 15 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
VICKI MARKS TRADING LIMITED | 15 févr. 2002 | 15 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
EARNSHAW CONSULTANTS LIMITED | 15 févr. 2002 | 15 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GEIST SPACES LIMITED | 30 oct. 2001 | 14 févr. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PENZANCE DRY DOCK LIMITED | 13 févr. 2002 | 13 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SCHOONER TAVERNS LIMITED | 12 févr. 2002 | 12 févr. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BATSON GROUNDCARE LTD | 12 févr. 2002 | 12 févr. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
P A BEAUMONT LIMITED | 12 févr. 2002 | 12 févr. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
M R SHARPE (HOLDINGS) LIMITED | 30 oct. 2001 | 12 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SCOTT MILLER LIMITED | 12 févr. 2002 | 12 févr. 2002 | Liquidation | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CREATUS LTD | 11 févr. 2002 | 11 févr. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
G. WHITE & SON LIMITED | 11 févr. 2002 | 11 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PEOPLE FACE2FACE LIMITED | 11 févr. 2002 | 11 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
STYNES KNIGHT & CO. LIMITED | 19 nov. 2001 | 11 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
UNIQUEFORCE LIMITED | 06 déc. 2001 | 08 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
RIFIFI (UK) LIMITED | 25 oct. 2001 | 08 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
J.P. MARTELL & CO. LIMITED | 07 févr. 2002 | 07 févr. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0