Dorothy May GRAEME - Page 244
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Dorothy |
Deuxième prénom | May |
Nom de famille | GRAEME |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 9882 |
Total | 9882 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISM CONSULTANCY LTD | 30 nov. 1995 | 30 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SOUTH WEST BUILDING & MAINTENANCE LIMITED | 29 nov. 1995 | 29 nov. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
IRISH GROUPAGE SERVICES LIMITED | 29 nov. 1995 | 29 nov. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LG 2011 LIMITED | 29 nov. 1995 | 29 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MULTIFIRE GROUP HOLDINGS LIMITED | 29 nov. 1995 | 29 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
QMS QUALITY & MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 29 nov. 1995 | 29 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PROHIRE SOFTWARE LIMITED | 28 nov. 1995 | 28 nov. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
M.J. HALLISSEY LIMITED | 27 nov. 1995 | 27 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AUSMIG LIMITED | 24 nov. 1995 | 24 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
D.D.M.C. LIMITED | 23 nov. 1995 | 23 nov. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CLADDEX LTD | 23 nov. 1995 | 23 nov. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
UNIQUE FITNESS LIMITED | 23 nov. 1995 | 23 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ALPHA PACKAGING (UK) LIMITED | 23 nov. 1995 | 23 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GROSVENOR FACILITIES MANAGEMENT LIMITED | 09 août 1995 | 21 nov. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ALBATROSS HOLDINGS LIMITED | 20 nov. 1995 | 20 nov. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TRANSGLOBAL FOODS RETAIL LIMITED | 20 nov. 1995 | 20 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WHOLESALE PLASTICS WINDOWS & CONSERVATORIES LIMITED | 13 oct. 1995 | 20 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FERNGALE LIMITED | 04 août 1995 | 17 nov. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
N.Y.F.R. LIMITED | 18 août 1995 | 16 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DIAMOND LETTING & PROPERTY MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 27 oct. 1995 | 15 nov. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
P. CHALK LIMITED | 14 nov. 1995 | 14 nov. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SUNRISESTAR LIMITED | 23 oct. 1995 | 14 nov. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GLEBE FARM (EXPORTS) LIMITED | 14 nov. 1995 | 14 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DAVID IAN FURNITURE LIMITED | 08 sept. 1995 | 13 nov. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CENTROMED INTERNATIONAL LIMITED | 17 juil. 1995 | 13 nov. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CLARIA HEADSETS LIMITED | 13 nov. 1995 | 13 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LANSDOWNE LAUNDERETTE LIMITED | 13 nov. 1995 | 13 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BESTBOOTS LIMITED | 10 nov. 1995 | 10 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
A1 WELDING & ERECTION SERVICES LIMITED | 10 nov. 1995 | 10 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BADDERTON LIMITED | 03 nov. 1995 | 10 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TRANSGLOBAL FOODSERVICE LIMITED | 09 nov. 1995 | 09 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HELENA HAEMOSTASIS SYSTEMS LIMITED | 08 nov. 1995 | 08 nov. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
A.M.J. PROPERTIES LIMITED | 08 nov. 1995 | 08 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PERFUME PLUS LIMITED | 06 nov. 1995 | 06 nov. 1995 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ALG CONSULTING LTD | 30 oct. 1995 | 06 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0