Dorothy May GRAEME - Page 186
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Dorothy |
Deuxième prénom | May |
Nom de famille | GRAEME |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 9882 |
Total | 9882 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FURNITURE BY DIGBY LIMITED | 09 juil. 1999 | 09 juil. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BLOOMSBURY PLANNING AND DESIGN LIMITED | 09 juil. 1999 | 09 juil. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
J & S DEVELOPMENTS LIMITED | 09 juil. 1999 | 09 juil. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BLACKPOLE STEAM CLEANING COMPANY LIMITED | 08 juil. 1999 | 08 juil. 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
W. FRISWELL AND SONS LIMITED | 08 juil. 1999 | 08 juil. 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SOUTH EAST PARKS LIMITED | 14 mai 1999 | 08 juil. 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FULL THROTTLE PROMOTIONS LIMITED | 08 juil. 1999 | 08 juil. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THE FOLKESTONE AND HYTHE CHRISTIAN BOOKSHOP LIMITED | 08 juil. 1999 | 08 juil. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ROSENDALE BUILDING SERVICES LIMITED | 07 juil. 1999 | 07 juil. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
M & L CEILINGS LIMITED | 07 juil. 1999 | 07 juil. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SALECARE LIMITED | 14 mai 1999 | 07 juil. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LETS DANCE UK LIMITED | 06 juil. 1999 | 06 juil. 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CHURCHILL RESIDENCES II LIMITED | 05 juil. 1999 | 05 juil. 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
K50 LIMITED | 05 juil. 1999 | 05 juil. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
K50 SERVICES LIMITED | 05 juil. 1999 | 05 juil. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GEORGE HOMES LIMITED | 02 juil. 1999 | 02 juil. 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
C.D.S. (NORTHERN) LIMITED | 02 juil. 1999 | 02 juil. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LIFETIME WEB SERVICES LIMITED | 02 juil. 1999 | 02 juil. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SMC (EXETER) LIMITED | 26 mai 1999 | 29 juin 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AUSTIN CONTRACT SERVICES LIMITED | 28 juin 1999 | 28 juin 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CAFFE BAR LIMITED | 28 juin 1999 | 28 juin 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DIGITALSONIC LIMITED | 10 juin 1999 | 28 juin 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
YOUNG MAN LIMITED | 14 mai 1999 | 28 juin 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LUDHAMGATE LIMITED | 14 juin 1999 | 28 juin 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
RESTALLS LIMITED | 28 juin 1999 | 28 juin 1999 | Liquidation | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ICON MOTOR CYCLES LIMITED | 25 juin 1999 | 25 juin 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HAWTHORNE ENGINEERING (MIDLANDS) LIMITED | 25 juin 1999 | 25 juin 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ANSON + JACKSON LIMITED | 24 juin 1999 | 24 juin 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
EUROPEAN VEHICLE DELIVERIES LIMITED | 24 juin 1999 | 24 juin 1999 | Liquidation | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
A T COMMUNICATIONS LIMITED | 12 mai 1999 | 23 juin 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
S.G. RENTALS LIMITED | 22 juin 1999 | 22 juin 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TORUS MEASUREMENT SYSTEMS LIMITED | 28 avr. 1999 | 21 juin 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED | 21 juin 1999 | 21 juin 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CASTLEGATE 796 LIMITED | 21 juin 1999 | 21 juin 1999 | Liquidation | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LIL' GIFT HUT LTD | 18 juin 1999 | 18 juin 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0