• Données
  • Grande-Bretagne
  • Entreprises
  • Rechercher des entreprises
  • Sanctions
  • Rechercher des sanctions
  • Dorothy May GRAEME - Page 186

    Personne physique

    Titre
    PrénomDorothy
    Deuxième prénomMay
    Nom de familleGRAEME
    Est un dirigeant de sociétéNon
    Nominations
    Actif0
    Inactif0
    Démissionné9882
    Total9882

    Nominations

    Dirigeants nommés
    Nommé(e) àDate de nominationDate de démissionStatut de la sociétéProfessionRôleAdressePays de résidenceNationalité
    FURNITURE BY DIGBY LIMITED09 juil. 199909 juil. 1999DissouteSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BLOOMSBURY PLANNING AND DESIGN LIMITED09 juil. 199909 juil. 1999DissouteSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    J & S DEVELOPMENTS LIMITED09 juil. 199909 juil. 1999DissouteSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    BLACKPOLE STEAM CLEANING COMPANY LIMITED08 juil. 199908 juil. 1999ActiveSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    W. FRISWELL AND SONS LIMITED08 juil. 199908 juil. 1999ActiveSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SOUTH EAST PARKS LIMITED14 mai 199908 juil. 1999ActiveSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    FULL THROTTLE PROMOTIONS LIMITED08 juil. 199908 juil. 1999DissouteSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    THE FOLKESTONE AND HYTHE CHRISTIAN BOOKSHOP LIMITED08 juil. 199908 juil. 1999DissouteSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ROSENDALE BUILDING SERVICES LIMITED07 juil. 199907 juil. 1999DissouteSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    M & L CEILINGS LIMITED07 juil. 199907 juil. 1999DissouteSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SALECARE LIMITED14 mai 199907 juil. 1999DissouteSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    LETS DANCE UK LIMITED06 juil. 199906 juil. 1999ActiveSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CHURCHILL RESIDENCES II LIMITED05 juil. 199905 juil. 1999ActiveSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    K50 LIMITED05 juil. 199905 juil. 1999DissouteSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    K50 SERVICES LIMITED05 juil. 199905 juil. 1999DissouteSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    GEORGE HOMES LIMITED02 juil. 199902 juil. 1999ActiveSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    C.D.S. (NORTHERN) LIMITED02 juil. 199902 juil. 1999DissouteSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    LIFETIME WEB SERVICES LIMITED02 juil. 199902 juil. 1999DissouteSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    SMC (EXETER) LIMITED26 mai 199929 juin 1999ActiveSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    AUSTIN CONTRACT SERVICES LIMITED28 juin 199928 juin 1999ActiveSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CAFFE BAR LIMITED28 juin 199928 juin 1999ActiveSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    DIGITALSONIC LIMITED10 juin 199928 juin 1999ActiveSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    YOUNG MAN LIMITED14 mai 199928 juin 1999ActiveSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    LUDHAMGATE LIMITED14 juin 199928 juin 1999DissouteSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    RESTALLS LIMITED28 juin 199928 juin 1999LiquidationSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ICON MOTOR CYCLES LIMITED25 juin 199925 juin 1999ActiveSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    HAWTHORNE ENGINEERING (MIDLANDS) LIMITED25 juin 199925 juin 1999DissouteSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ANSON + JACKSON LIMITED24 juin 199924 juin 1999ActiveSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    EUROPEAN VEHICLE DELIVERIES LIMITED24 juin 199924 juin 1999LiquidationSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    A T COMMUNICATIONS LIMITED12 mai 199923 juin 1999ActiveSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    S.G. RENTALS LIMITED22 juin 199922 juin 1999DissouteSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    TORUS MEASUREMENT SYSTEMS LIMITED28 avr. 199921 juin 1999ActiveSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED21 juin 199921 juin 1999DissouteSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    CASTLEGATE 796 LIMITED21 juin 199921 juin 1999LiquidationSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British
    LIL' GIFT HUT LTD18 juin 199918 juin 1999DissouteSecrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0