Dorothy May GRAEME - Page 39
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Dorothy |
Deuxième prénom | May |
Nom de famille | GRAEME |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 9882 |
Total | 9882 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONTROL TEXTILES LIMITED | 19 nov. 2003 | 19 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MOCKBEGGAR PACKERS LIMITED | 19 nov. 2003 | 19 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FOREMAN & MARTIN LIMITED | 19 nov. 2003 | 19 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
G.P. RESTAURANTS LIMITED | 19 nov. 2003 | 19 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MAISON FOODS (TREWOON) LIMITED | 19 nov. 2003 | 19 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
INSTANT ACCESS UK LIMITED | 19 nov. 2003 | 19 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SYSTEMATIC SOLUTIONS LIMITED | 17 nov. 2003 | 19 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BROOKLANDS NURSERIES LIMITED | 18 nov. 2003 | 18 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
STACE ASSOCIATES LIMITED | 18 nov. 2003 | 18 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
R.J. SMITH (SOUTH EAST) LIMITED | 18 nov. 2003 | 18 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
STONE COMMERCIAL MANAGEMENT LIMITED | 18 nov. 2003 | 18 nov. 2003 | Liquidation | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
A. THAMES & COOK LIMITED | 17 nov. 2003 | 17 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
H & H ENGINEERING LIMITED | 17 nov. 2003 | 17 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LAMART LIMITED | 17 nov. 2003 | 17 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TOPFLIGHT TECHNOLOGY LIMITED | 06 oct. 2003 | 17 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DOUGLAS SIGNS LIMITED | 14 nov. 2003 | 14 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HCRP LIMITED | 14 nov. 2003 | 14 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ELLANDAY LIMITED | 14 nov. 2003 | 14 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GEESON FINANCIAL SERVICES LIMITED | 14 nov. 2003 | 14 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SNOWDROP CLEANING SERVICES LIMITED | 14 nov. 2003 | 14 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DARREN DOBSON JOINERY LIMITED | 13 nov. 2003 | 13 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
COLIN BREAR ADVERTISING & MARKETING LIMITED | 13 nov. 2003 | 13 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
H.N.F. CONSULTANCY LIMITED | 12 nov. 2003 | 12 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CDY CEILINGS & PARTITIONS LIMITED | 12 nov. 2003 | 12 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PROFITSEVOLUTION.CO.UK LIMITED | 12 nov. 2003 | 12 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
D ALLUM FABRICATIONS LIMITED | 12 nov. 2003 | 12 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
W L M MOWERS LIMITED | 12 nov. 2003 | 12 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
OLDFIELDS DEVELOPMENTS LIMITED | 12 nov. 2003 | 12 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CHILTERNS (EAST YORKSHIRE) LIMITED | 12 nov. 2003 | 12 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
D.I. BONNER LIMITED | 12 nov. 2003 | 12 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CAREAVAN LTD | 30 sept. 2003 | 12 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ISLANDBREEZE LIMITED | 09 sept. 2003 | 12 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TRICELL GLOBAL LIMITED | 14 août 2003 | 12 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SCARBOROUGH TANDOORI LIMITED | 11 nov. 2003 | 11 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BRECKON & BRECKON (LETTING & MANAGEMENT) LTD | 11 nov. 2003 | 11 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0