Dorothy May GRAEME - Page 196
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Dorothy |
Deuxième prénom | May |
Nom de famille | GRAEME |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 9882 |
Total | 9882 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRACO RECRUITMENT LIMITED | 22 janv. 1999 | 22 janv. 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
EQUISYS TIMEMASTER LTD | 22 janv. 1999 | 22 janv. 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ORCHARDRISE LIMITED | 23 déc. 1998 | 22 janv. 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FRIENDLY HOUSE WANDERERS LIMITED | 22 janv. 1999 | 22 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WILDTRAK LIMITED | 22 janv. 1999 | 22 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THE L E CONSULTANCY LIMITED | 22 janv. 1999 | 22 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
UNIQUE PLANT LIMITED | 22 janv. 1999 | 22 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PREMIER OILS LIMITED | 22 janv. 1999 | 22 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ASSOCIATED COMMERCIAL INDUSTRIAL BUILDERS LIMITED | 22 janv. 1999 | 22 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
RIVERDALE WASTE PAPER LIMITED | 21 janv. 1999 | 21 janv. 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
RJT PROCESS LIMITED | 21 janv. 1999 | 21 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PAUL RIVETT LIMITED | 20 janv. 1999 | 20 janv. 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
INDUSTRIAL STORAGE INSTALLATIONS LIMITED | 20 janv. 1999 | 20 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ADVANCED CONTROL PROJECTS LIMITED | 27 nov. 1998 | 20 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GP TOOLS LIMITED | 19 janv. 1999 | 19 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
INDIGO PRODUCTS LIMITED | 10 nov. 1998 | 18 janv. 1999 | Liquidation | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ROE LIMITED | 15 janv. 1999 | 15 janv. 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BOCCHETTA CERAMICA LIMITED | 21 déc. 1998 | 15 janv. 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TORRY LIMITED | 02 nov. 1998 | 15 janv. 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MOBILTEK LIMITED | 15 janv. 1999 | 15 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CHAMPION SITE SERVICES LIMITED | 15 janv. 1999 | 15 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DEE LANDSCAPES LIMITED | 14 janv. 1999 | 14 janv. 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
T-MEX LIMITED | 14 janv. 1999 | 14 janv. 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CAREY LEISURE LIMITED | 14 janv. 1999 | 14 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BEST VALUE SERVICES LIMITED | 13 janv. 1999 | 13 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GLOBEX MANAGEMENT LIMITED | 12 janv. 1999 | 12 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GRANDE BOUCHE LIMITED | 12 janv. 1999 | 12 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PEAK INTERIOR CONTRACTS LIMITED | 25 nov. 1998 | 11 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
S&S (TONBRIDGE) LIMITED | 22 oct. 1998 | 07 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PENDRAGON FURNITURE LIMITED | 20 oct. 1998 | 06 janv. 1999 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PRODIGY INTERNATIONAL LIMITED | 06 janv. 1999 | 06 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TAKE HEED ELECTRICAL LIMITED | 06 janv. 1999 | 06 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MIKE KING FARM & COUNTRY LIMITED | 05 janv. 1999 | 05 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
03691434 LIMITED | 04 janv. 1999 | 04 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MEDWAY ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES LIMITED | 31 déc. 1998 | 31 déc. 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0