Dorothy May GRAEME - Page 230
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Dorothy |
Deuxième prénom | May |
Nom de famille | GRAEME |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 9882 |
Total | 9882 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE SOFTWARE LTD | 04 déc. 1996 | 04 déc. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SERVE U COACHING LIMITED | 05 nov. 1996 | 03 déc. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GLOBAL SIGNS & ENGRAVING LIMITED | 02 déc. 1996 | 02 déc. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
B. & E. BOYS LIMITED | 02 déc. 1996 | 02 déc. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BRUNEL TRUSTEES (NORTH WEST) LIMITED | 02 déc. 1996 | 02 déc. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SELF INVESTED PERSONAL PENSIONS LIMITED | 02 déc. 1996 | 02 déc. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ROCKYWATERS LIMITED | 13 nov. 1996 | 02 déc. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ARRESTAPEST (GIDDING) LIMITED | 29 nov. 1996 | 29 nov. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ACACIAWAY LIMITED | 07 nov. 1996 | 29 nov. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
UNITED BUYING GROUP LIMITED | 29 nov. 1996 | 29 nov. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PRINCIPIA ESTATE & ASSET MANAGEMENT LTD | 27 nov. 1996 | 27 nov. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
OLYMPIA HOMES LIMITED | 13 nov. 1996 | 27 nov. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AGILIT LIMITED | 26 nov. 1996 | 26 nov. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DRAWMER LIMITED | 26 nov. 1996 | 26 nov. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
IDOM CONSULTING LIMITED | 26 nov. 1996 | 26 nov. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
YOURS TRULY BRIDAL HOUSE LIMITED | 25 nov. 1996 | 25 nov. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AUTOFEEDS LIMITED | 25 nov. 1996 | 25 nov. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PEYEMGEE LIMITED | 25 nov. 1996 | 25 nov. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ARMATONE TECHNOLOGY LIMITED | 22 nov. 1996 | 22 nov. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TUDOR PARK ESTATES (SALES) LIMITED | 22 nov. 1996 | 22 nov. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PAIN AU CHOCOLAT LIMITED | 22 nov. 1996 | 22 nov. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CYCLONE MUSIC PRODUCTIONS LIMITED | 22 nov. 1996 | 22 nov. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ESKDALE STONE LIMITED | 22 nov. 1996 | 22 nov. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LARCHSTAR LIMITED | 20 août 1996 | 22 nov. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AVAGGO (MARBLE) LIMITED | 22 nov. 1996 | 22 nov. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
IN TOUCH COMMUNICATION CABLING LIMITED | 22 nov. 1996 | 22 nov. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BURGUNDY GLOBAL LIMITED | 22 nov. 1996 | 22 nov. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GARRODS LOSS ADJUSTERS LIMITED | 20 nov. 1996 | 20 nov. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
P.L. TAYLOR ELECTRICAL SERVICES LIMITED | 19 nov. 1996 | 19 nov. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
P.J. COLE (SOUTHERN) LIMITED | 19 nov. 1996 | 19 nov. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CONCEPT ADVANCED TECHNOLOGY LIMITED | 19 nov. 1996 | 19 nov. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
RAPIDFLAME LIMITED | 19 nov. 1996 | 19 nov. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WEST MIDLAND GLASS CENTRE LIMITED | 19 nov. 1996 | 19 nov. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
EXPRESS PLANT HIRE LIMITED | 25 oct. 1996 | 19 nov. 1996 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PAVOUND LIMITED | 18 nov. 1996 | 18 nov. 1996 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0