Dorothy May GRAEME - Page 93
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Dorothy |
Deuxième prénom | May |
Nom de famille | GRAEME |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 9882 |
Total | 9882 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYFORD DEVELOPMENT LIMITED | 15 nov. 2002 | 15 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HERITAGE SUPERMARKETS LIMITED | 15 nov. 2002 | 15 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PROPOSAL WRITERS LIMITED | 15 nov. 2002 | 15 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SAVIL LIMITED | 15 nov. 2002 | 15 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CARTERS HEATING & PLUMBING LIMITED | 15 nov. 2002 | 15 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SHOES UK LIMITED | 14 nov. 2002 | 14 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
S. RIDGEWAY LIMITED | 14 nov. 2002 | 14 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LANDMARK HEALTH CONSULTING LIMITED | 13 nov. 2002 | 13 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BOOTH MARANATHA CONSULTANTS LIMITED | 13 nov. 2002 | 13 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AMOURS DE BIJOUX LIMITED | 13 nov. 2002 | 13 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CONSTRUCTION SYSTEMS (LIVERPOOL) LIMITED | 13 nov. 2002 | 13 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
R H GREENWOOD & SONS LIMITED | 13 nov. 2002 | 13 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HESSLEWOOD HALL LIMITED | 13 nov. 2002 | 13 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ST. MARGARET'S LIMITED | 13 nov. 2002 | 13 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GREG BANHAM LIMITED | 13 nov. 2002 | 13 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CITY CLASSICS COVENTRY LIMITED | 12 nov. 2002 | 12 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
W G PETHERICK LTD | 12 nov. 2002 | 12 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LANDWARD LIMITED | 12 nov. 2002 | 12 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
R. DRINKWATER & SON LIMITED | 11 nov. 2002 | 11 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CDF HOME-FIT TOWBARS LIMITED | 11 nov. 2002 | 11 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PRINCESS POTTERY LIMITED | 10 sept. 2002 | 11 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
D. SCOTT & SONS TILING LIMITED | 08 nov. 2002 | 08 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FLAMESHIELD PRODUCTS LIMITED | 08 nov. 2002 | 08 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HRS BUILDING & JOINERY CONTRACTORS LIMITED | 08 nov. 2002 | 08 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PLACE2PLACE LIMITED | 08 nov. 2002 | 08 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
L & P LIMITED | 08 nov. 2002 | 08 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PR CARTEL LIMITED | 08 nov. 2002 | 08 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
XL MOTORS LIMITED | 07 nov. 2002 | 07 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FORDFIELD HOUSE NURSERY LIMITED | 07 nov. 2002 | 07 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CENTURY DEVELOPMENTS LIMITED | 07 nov. 2002 | 07 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SILVERTAP LIMITED | 07 nov. 2002 | 07 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ALEXANDER ACCESSORIES LIMITED | 07 nov. 2002 | 07 nov. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
COTON PARK BUSINESS SERVICES LIMITED | 07 nov. 2002 | 07 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DRAGGIN JEANS 2001 (UK) LIMITED | 07 nov. 2002 | 07 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
E D EGGLESTON LIMITED | 07 nov. 2002 | 07 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0