Dorothy May GRAEME - Page 38
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Dorothy |
Deuxième prénom | May |
Nom de famille | GRAEME |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 9882 |
Total | 9882 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNAPTON FARMS LIMITED | 25 nov. 2003 | 25 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
KEMP SIGNS LIMITED | 25 nov. 2003 | 25 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CLUBWISE UK LIMITED | 25 nov. 2003 | 25 nov. 2003 | Active | Secr étaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ENVA PLASTICS LIMITED | 25 nov. 2003 | 25 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
KING & SONS KENT LIMITED | 21 août 2003 | 25 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
C & J SERVICES (MIDLANDS) LIMITED | 25 nov. 2003 | 25 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
JOHN SUMMERS AMUSEMENT SERVICES LIMITED | 25 nov. 2003 | 25 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
KENT FOOTCARE LIMITED | 24 nov. 2003 | 24 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
J.L. ANDREWS BUILDING LIMITED | 24 nov. 2003 | 24 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
J DAVIDSON ROOFING LIMITED | 24 nov. 2003 | 24 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FOUR SEASONS GARDEN SERVICES LIMITED | 24 nov. 2003 | 24 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BLOOMTIME LIMITED | 24 nov. 2003 | 24 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WISDOM OF NATURE LIMITED | 24 nov. 2003 | 24 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LA VUE LIMITED | 24 nov. 2003 | 24 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MARK HILL ACCOUNTANTS LIMITED | 24 nov. 2003 | 24 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
S & D SUPERMARKET LIMITED | 21 nov. 2003 | 21 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
UOI LIMITED | 21 nov. 2003 | 21 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
UPTOWN PROPERTY LIMITED | 21 nov. 2003 | 21 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DEANNA JANE LIMITED | 21 nov. 2003 | 21 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
L.D.C. RESTORATION LIMITED | 21 nov. 2003 | 21 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
S & D INVESTMENT PROPERTY LIMITED | 21 nov. 2003 | 21 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ALPHATEC RECRUITMENT LIMITED | 21 nov. 2003 | 21 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MAYHEAD TRAVEL LIMITED | 21 nov. 2003 | 21 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WILLOWPOINT ENTERPRISES LIMITED | 19 août 2003 | 20 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CHOICES - YOUR MORTGAGE SOLUTIONS LIMITED | 20 nov. 2003 | 20 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
IRTEM REALISATIONS LIMITED | 20 nov. 2003 | 20 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MOOPA DESIGN LIMITED | 19 nov. 2003 | 19 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AQUACARE LIMITED | 19 nov. 2003 | 19 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MORGAN LLOYD JONES PROJECT MANAGEMENT LIMITED | 19 nov. 2003 | 19 nov. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AHM SERVICES LIMITED | 19 nov. 2003 | 19 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MAISON FOODS (ROCHE) LIMITED | 19 nov. 2003 | 19 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
K.R. RESTAURANTS LIMITED | 19 nov. 2003 | 19 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THE WHITSTABLE ICE CREAM COMPANY LIMITED | 19 nov. 2003 | 19 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
INSANITY ARTISTS AGENCY LIMITED | 19 nov. 2003 | 19 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MAISON FOODS (TRURO) LIMITED | 19 nov. 2003 | 19 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0